Buscador CIF Logo

Actos BORME Goygen 2016 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Goygen 2016 Sl

Actos BORME Goygen 2016 Sl - B87687646

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Goygen 2016 Sl con CIF B87687646

馃敊 Perfil de Goygen 2016 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Goygen 2016 Sl

01 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VIDAL MONFERRER ROSA MARIA. Apoderado: NAVARRO GONZALEZ ANTONIO JOSE;VIDALMONFERRER ROSA MARIA;MARTINEZ ESTORS ALBERTO Datos registrales. T 41437 , F 175, S 8, H M 641354, I/A 8 (25.01.23).

04 de Julio de 2022
Reelecciones. Consejero: BROSETA DUPRE MANUEL;NAVARRO GONZALEZ ANTONIO JOSE;TRIGO SIERRA LUISFERNANDO;VIDAL MONFERRER ROSA MARIA. Secretario: NAVARRO GONZALEZ ANTONIO JOSE. Presidente: BROSETADUPRE MANUEL. Datos registrales. T 41437 , F 175, S 8, H M 641354, I/A 7 (27.06.22).

28 de Abril de 2021
Modificaciones estatutarias. 25. . Datos registrales. T 35687 , F 140, S 8, H M 641354, I/A 5 (21.04.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LAINZ ARROYO MIGUEL. Datos registrales. T 35687 , F 140, S 8, H M 641354, I/A 6 (21.04.21).

24 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BROSETA DUPRE MANUEL ANDRES;NAVARRO GONZALEZ ANTONIO JOSE;VIDALMONFERRER ROSA MARIA;TRIGO SIERRA LUIS FERNANDO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 2陋 elnombramiento como apoderados de BROSETA DUPRE MANUEL ANDRES, NAVARRO GONZALEZ ANTONIO JOSE, VIDALMONFERRER ROSA MARIA y de TRIGO SIERRA LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 35687 , F 137, S 8, H M 641354, I/A 2(27.10.17).

08 de Enero de 2019
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO GONZALEZ ANTONIO JOSE;VIDAL MONFERRER ROSA MARIA;MARTINEZ ESTORSALBERTO Datos registrales. T 35687 , F 139, S 8, H M 641354, I/A 4 (27.12.18).

19 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: EXPLOTACIONES DE LA SIERRA MARIOLA SL. Representan: BROSETA CASTELOS MANUEL.Nombramientos. Consejero: LAINZ ARROYO MIGUEL. Datos registrales. T 35687 , F 139, S 8, H M 641354, I/A 3 (11.09.18).

07 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Secretario: NAVARRO GONZALEZ ANTONIO JOSE. Presidente: BROSETA DUPRE MANUEL. Datos registrales.T 35687 , F 137, S 8, H M 641354, I/A 2 (27.10.17).

22 de Marzo de 2017
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 14.11.16. Objeto social: la adquisici贸n, tenencia, disfrute y administraci贸n, direcci贸n ygesti贸n de valores y/o acciones representativas de los fondos propios tanto de sociedades o entidades constituidas en territorioespa帽ol como de entidades no residentes en territorio espa帽ol. Domicilio: C/ GOYA 29 (MADRID). Capital: 5.331,60 Euros.Nombramientos. Representan: BROSETA CASTELOS MANUEL. Consejero: BROSETA DUPRE MANUEL;NAVARRO GONZALEZANTONIO JOSE;TRIGO SIERRA LUIS FERNANDO;VIDAL MONFERRER ROSA MARIA;EXPLOTACIONES DE LA SIERRAMARIOLA SL. Datos registrales. T 35687 , F 131, S 8, H M 641354, I/A 1 (13.03.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n