Buscador CIF Logo

Actos BORME Graficas San Quintin Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Graficas San Quintin Sa

Actos BORME Graficas San Quintin Sa - A58588948

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Graficas San Quintin Sa con CIF A58588948

馃敊 Perfil de Graficas San Quintin Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Graficas San Quintin Sa

14 de Enero de 2021
Extinci贸n. Datos registrales. T 47190 , F 33, S 8, H B 46466, I/A 35 (30.12.20).

26 de Agosto de 2020
Revocaciones. APOD.MANCOMU: SOSTRES CASADEVALL FERNANDO. Datos registrales. T 47190 , F 32, S 8, H B 46466, I/A33 (18.08.20).

Nombramientos. APOD.MANCOMU: COSTA CENTENA JOAQUIN. Datos registrales. T 47190 , F 32, S 8, H B 46466, I/A 34(18.08.20).

14 de Agosto de 2020
Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, ACCIONISTA UNICO: FREIXENET S.A. Datos registrales. T 47190 ,F 31, S 8, H B 46466, I/A 32 ( 6.08.20).

10 de Marzo de 2020
Revocaciones. APOD.MANCOMU: BERND FRIEDRICH KURT HALBACH. Datos registrales. T 47190 , F 31, S 8, H B 46466, I/A31 ( 2.03.20).

09 de Marzo de 2020
Fe de erratas: En el BORME no.195/2018 y con referencia 404845 SE RECTIFICA EL NOMBRE DEL APODERADO BERNDFRIEDRICH KURT HALBACH. Datos registrales. T 23023 , F 138, S 8, H B 46466, I/A 26 ( 2.10.18).

27 de Enero de 2020
Revocaciones. APODERAD.SOL: ABEL LLUCH JOSE LUIS. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: HERRERO MARTINFRANCISCO;ABEL LLUCH JOSE LUIS. APOD.MANCOMU: GUTIERREZ FUNES BERNARD. Datos registrales. T 23023 , F 140, S8, H B 46466, I/A 29 (17.01.20).

Nombramientos. APOD.MANCOMU: SOSTRES CASADEVALL FERNANDO;MARTINA ROTHE OBREGON. Datos registrales. T23023 , F 142, S 8, H B 46466, I/A 30 (17.01.20).

13 de Noviembre de 2019
Revocaciones. APOD.MANCOMU: FERRER NOGUER PEDRO. Datos registrales. T 23023 , F 140, S 8, H B 46466, I/A 28 (4.11.19).

04 de Julio de 2019
Revocaciones. APOD.MANCOMU: SANCHEZ LOMBARTE ANSELM. Datos registrales. T 23023 , F 140, S 8, H B 46466, I/A 27(25.06.19).

09 de Octubre de 2018
Nombramientos. APOD.MANCOMU: FERRER NOGUER PEDRO;THOMAS MANFRED SCHOLL;BERND FREIDRICH KURTHALBACH;MARIMON PRATS ANTONIO;AZCUNE ELORZA NEREA LEONOR. Datos registrales. T 23023 , F 138, S 8, H B 46466,I/A 26 ( 2.10.18).

12 de Septiembre de 2018
Revocaciones. APODERADO: BONET FERRER EUDALDO. APODERAD.SOL: FERRER NOGUER PEDRO;HEVIA FERRERENRIQUE JOSE. Nombramientos. APODERAD.SOL: MARIMON PRATS ANTONIO;AZCUNE ELORZA NEREA LEONOR. Datosregistrales. T 23023 , F 138, S 8, H B 46466, I/A 25 ( 5.09.18).

07 de Septiembre de 2018
Revocaciones. CONSEJERO: FERRER NOGUER PEDRO. SECRETARIO: FERRER NOGUER PEDRO. CONS. DELEG.: FERRERNOGUER PEDRO. CONSEJERO: HEVIA FERRER ENRIQUE JOSE;BONET FERRER EUDALDO. PRESIDENTE: BONET FERREREUDALDO. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: FERRER NOGUER PEDRO;THOMAS MANFRED SCHOLL. Modificacionesestatutarias. ARTS.14,25,26 Y 27(SIN CONTENIDO).-CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. ART.28.-FIJACION DEL INICIO YCIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE ENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA A脩O.Datos registrales. T 23023 , F 137, S 8, H B 46466, I/A 24 (31.08.18).

24 de Agosto de 2018
Nombramientos. APOD.MANCOMU: FERRER NOGUER PEDRO;SANCHEZ LOMBARTE ANSELM. Datos registrales. T 23023 , F136, S 8, H B 46466, I/A 23 (16.08.18).

24 de Abril de 2015
Revocaciones. CONSEJERO: FERRER SALA JOSE. PRESIDENTE: FERRER SALA JOSE. CONS. DELEG.: FERRER SALA JOSE.CONSEJERO: FERRER SALA PILAR;FERRER SALA CARMEN. SECRETARIO: FERRER SALA PILAR. Nombramientos.CONSEJERO: FERRER NOGUER PEDRO. SECRETARIO: FERRER NOGUER PEDRO. CONS. DELEG.: FERRER NOGUERPEDRO. CONSEJERO: HEVIA FERRER ENRIQUE JOSE;BONET FERRER EUDALDO. PRESIDENTE: BONET FERRER EUDALDO.Datos registrales. T 23023 , F 136, S 8, H B 46466, I/A 22 (16.04.15).

03 de Julio de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: ABEL LLUCH JOSE LUIS. Datos registrales. T 23023 , F 134, S 8, H B 46466, I/A 19(25.06.14).

Nombramientos. APODERAD.SOL: FERRER NOGUER PEDRO. Datos registrales. T 23023 , F 135, S 8, H B 46466, I/A 20(25.06.14).

Nombramientos. APODERAD.SOL: HEVIA FERRER ENRIQUE JOSE. Datos registrales. T 23023 , F 135, S 8, H B 46466, I/A 21(25.06.14).

25 de Abril de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: FERRER SALA DOLORES. Datos registrales. T 23023 , F 134, S 8, H B 46466, I/A 18 (15.04.14).

05 de Julio de 2013
Revocaciones. SECRETARIO: FERRER SALA DOLORES. Nombramientos. SECRETARIO: FERRER SALA PILAR. Datos

05 de Noviembre de 2009
Nombramientos. CONSEJERO: FERRER SALA JOSE. PRESIDENTE: FERRER SALA JOSE. CONS. DELEG.: FERRER SALAJOSE. CONSEJERO: FERRER SALA PILAR;FERRER SALA CARMEN;FERRER SALA DOLORES. SECRETARIO: FERRER SALADOLORES. Datos registrales. T 23023 , F 133, S 8, H B 46466, I/A 16 (27.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n