Actos BORME de Grandes Areas Comerciales De Aragon Sa
07 de Diciembre de 2023Modificaciones estatutarias. Art铆culo 18潞.- La Junta General, tanto ordinaria como extraordinaria, ser谩 convocada mediante anunciop煤blico en la p谩gina web de la sociedad. Para el 煤nico supuesto de supresi贸n o eliminaci贸n de la p谩gina web de la sociedad, la cual seajustar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 11 bis de la Ley de. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:wtczaragoza.com. Datos registrales. T 3766 , F 197, S 8, H Z 2743, I/A 44 (30.11.23).
14 de Agosto de 2023Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ARRESE AZNAREZ FRANCISCO. Nombramientos. Consejero:ARRESE ANDREU DIEGO. Reelecciones. Consejero: 2003 SL;LASUEN LAPUENTE LUIS ALBERTO;RODRIGO ORTEGA JOSEANTONIO;GESPLAZA 14 SL;FORCEN MARQUEZ JUAN. Presidente: FORCEN MARQUEZ JUAN. SecreNoConsj: FORCENMARQUEZ ANA. Datos registrales. T 3312 , F 154, S 8, H Z 2743, I/A 43 ( 8.08.23).
18 de Noviembre de 2022Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DESARROLLOS URBANISTICOS CAMBRILS 2011 SOCIEDAD LI. Datosregistrales. T 3312 , F 153, S 8, H Z 2743, I/A 42 (14.11.22).
22 de Noviembre de 2021Fe de erratas: El n煤mero de la inscripci贸n es el 40陋 (y no 41 como por error se hizo constar). Datos registrales. T 3312 , F 152, S 8,H Z 2743, I/A 40 (10.12.18).
16 de Noviembre de 2021Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INVERSIONES GRANCASA SA. Datos registrales. T 3312 , F 153, S 8, H Z 2743,I/A 41 ( 8.11.21).
17 de Diciembre de 2018Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 2.250.000,32 Euros. Datos registrales. T 3312 , F 152, S 8, H Z 2743, I/A 41(10.12.18).
29 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: FORCEN MARQUEZ JUAN. Nombramientos. Apoderado: FORCEN MARQUEZ JUAN. Datos
23 de Octubre de 2018Reelecciones. SecreNoConsj: FORCEN MARQUEZ ANA. Consejero: 2003 SL;LASUEN LAPUENTE LUIS ALBERTO;RODRIGOORTEGA JOSE ANTONIO;GESPLAZA 14 SL;FORCEN MARQUEZ JUAN. Presidente: FORCEN MARQUEZ JUAN. Consejero:ARRESE AZNAREZ FRANCISCO. Datos registrales. T 3312 , F 150, S 8, H Z 2743, I/A 38 (16.10.18).
28 de Febrero de 2018Fe de erratas: El capital social se amplia en 3.000.000,78 euros y se desembolsa en un 25%, en la cantidad de 750.000,20 euros.Datos registrales. T 3312 , F 149, S 8, H Z 2743, I/A 37 (14.02.18).
21 de Febrero de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.000.000,78 Euros. Desembolsado: 3.000.000,78 Euros. Resultante Suscrito: 3.390.385,74 Euros.Resultante Desembolsado: 3.390.385,74 Euros. Datos registrales. T 3312 , F 149, S 8, H Z 2743, I/A 37 (14.02.18).
22 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ARLADI SL;COMPANY RENT HOMES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM;RODRIGOORTEGA JOSE ANTONIO;GESPLAZA 14 SL;FORCEN MARQUEZ JUAN;ARRESE AZNAREZ FRANCISCO. Con.Delegado:FORCEN MARQUEZ JUAN. Presidente: FORCEN MARQUEZ JUAN. SecreNoConsj: FORCEN MARQUEZ ANA. Nombramientos.Consejero: 2003 SL;LASUEN LAPUENTE LUIS ALBERTO;RODRIGO ORTEGA JOSE ANTONIO;GESPLAZA 14 SL;FORCENMARQUEZ JUAN. Presidente: FORCEN MARQUEZ JUAN. Consejero: ARRESE AZNAREZ FRANCISCO. Con.Delegado: FORCENMARQUEZ JUAN. SecreNoConsj: FORCEN MARQUEZ ANA. Datos registrales. T 3312 , F 149, S 8, H Z 2743, I/A 36 (12.08.13).
14 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: FORCEN BUENO ISABELO ALFONSO. Presidente: FORCEN BUENO ISABELO ALFONSO.Nombramientos. Presidente: FORCEN MARQUEZ JUAN. Datos registrales. T 3312 , F 149, S 8, H Z 2743, I/A 35 ( 4.03.13).
21 de Octubre de 2010Cambio de domicilio social. C/ MARIA ZAMBRANO 31 - TORRE ESTE, PLANTA SEMISOTA (ZARAGOZA). Datos registrales. T3312 , F 149, S 8, H Z 2743, I/A 34 ( 8.10.10).
28 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ARANAZ BLASCO JOSE. Presidente: ARANAZ BLASCO JOSE. Consejero: FORMA SEIS SA.Vicepresid.: FORMA SEIS SA. Consejero: MAYAYO SAINZ VALERIANO. Vicepresid.: MAYAYO SAINZ VALERIANO. Consejero:BARRAGAN TORRES JESUS;CENTRO DE FORMACION CONTINUADA SL;OCTAVIO SANZ ENRIQUE;REY FILLATANTONIO;ROYO PENA RAMON;VILLANUEVA ALAPONT ALFONSO. Co.De.Ma.So: FORMA SEIS SA;MAYAYO SAINZ VALERIANO.SecreNoConsj: FORCEN MARQUEZ ANA. Nombramientos. Consejero: ARLADI SL;FORCEN BUENO ISABELOALFONSO;COMPANY RENT HOMES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM;RODRIGO ORTEGA JOSE ANTONIO;GESPLAZA 14SL;FORCEN MARQUEZ JUAN;ARRESE AZNAREZ FRANCISCO. Presidente: FORCEN BUENO ISABELO ALFONSO.SecreNoConsj: FORCEN MARQUEZ ANA. Datos registrales. T 3312 , F 147, S 8, H Z 2743, I/A 32 (19.05.10).
Nombramientos. Con.Delegado: FORCEN MARQUEZ JUAN. Datos registrales. T 3312 , F 147, S 8, H Z 2743, I/A 33 (19.05.10).
25 de Marzo de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 44.806,86 Euros. Desembolsado: 44.806,86 Euros. Resultante Suscrito: 390.384,96 Euros.Resultante Desembolsado: 390.384,96 Euros. Otros conceptos: Cancelada la anotaci贸n al haberse celebrado la Junta de 30 dejunio de 2009 con la intervenci贸n notarial. Datos registrales. T 3312 , F 147, S 8, H Z 2743, I/A 31 (15.03.10).
16 de Julio de 2009Otros conceptos: Se solicita la asistencia de notario a la Junta de la Sociedad "GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGON,S.A.", a celebrar el 30 de junio de 2009, seg煤n resulta de la convocatoria publicada el 28 de mayo de 2009 en el BORME. Datosregistrales. T 3312 , F 147, S 8, H Z 2743, I/A A ( 7.07.09).