Buscador CIF Logo

Actos BORME Granja Cerromonte Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Granja Cerromonte Sl

Actos BORME Granja Cerromonte Sl - B05184510

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Avila para Granja Cerromonte Sl con CIF B05184510

馃敊 Perfil de Granja Cerromonte Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Avila

Actos BORME de Granja Cerromonte Sl

25 de Agosto de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ DIAZ FERNANDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALEJANDRA TIRADO NIEBLA.Datos registrales. T 177, L 135, F 91, S 8, H AV 3558, I/A 11 (18.08.22).

03 de Abril de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALTA MORA脩A SOCIEDAD COOPERATIVA. Presidente: HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO.Consejero: HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO;HERRERO VERDUGO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: ALTAMORA脩A SOCIEDAD COOPERATIVA;HERRERO VERDUGO FERNANDO;HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO. Presidente:HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 148, L 106, F 58, S 8, H AV 3558, I/A 10 (20.03.20).

27 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALTA MORA脩A SOCIEDAD COOPERATIVA;HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO. Presidente:HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO. Consejero: HERRERO VERDUGO FERNANDO. SecreNoConsj: CABALLERO LOPEZGERMAN. Nombramientos. Consejero: ALTA MORA脩A SOCIEDAD COOPERATIVA;HERRERO VERDUGOFERNANDO;HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO. Presidente: HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO. SecreNoConsj:CABALLERO LOPEZ GERMAN. Datos registrales. T 148, L 106, F 58, S 8, H AV 3558, I/A 9 (18.02.15).

20 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: GRUPO DE NEGOCIOS DUERO SA;CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA.Nombramientos. Consejero: HERRERO VERDUGO FERNANDO. Datos registrales. T 148, L 106, F 58, S 8, H AV 3558, I/A 8(10.03.14).

15 de Febrero de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: HOLGADO GONZALEZ VIDAL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ MARTIN JOSEANTONIO. Datos registrales. T 148, L 106, F 57, S 8, H AV 3558, I/A 7 ( 2.02.12).

08 de Febrero de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 170.925,00 Euros. Resultante Suscrito: 683.700,00 Euros. Datos registrales. T 148, L 106, F 57, S8, H AV 3558, I/A 6 (30.01.12).

29 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: HOLGADO GONZALEZ VIDAL. Presidente: HOLGADO GONZALEZ VIDAL. Nombramientos.Consejero: HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO. Presidente: HERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 110,L 68, F 91, S 8, H AV 3558, I/A 5 ( 7.11.11).

25 de Noviembre de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 261.225,00 Euros. Resultante Suscrito: 512.775,00 Euros. Datos registrales. T 110, L 68,F 91, S 8, H AV 3558, I/A 4 (10.11.10).

03 de Agosto de 2010
Fe de erratas: El cargo es Secretario No consejero. Datos registrales. T 110, L 68, F 90, S 8, H AV 3558, I/A 3 (27.10.09).

18 de Noviembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: HOLGADO GONZALEZ VIDAL;CORDERO GOMEZ RAQUEL;HERRERO VERDUGOFERNANDO;MARTIN HERRERO JESUS ALBERTO. Presidente: HOLGADO GONZALEZ VIDAL. Nombramientos. Consejero:GRUPO DE NEGOCIOS DUERO SA;CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA;ALTA MORA脩A SOCIEDADCCOPERATIVA;HOLGADO GONZALEZ VIDAL. Presidente: HOLGADO GONZALEZ VIDAL. Secretario: CABALLERO LOPEZGERMAN. Datos registrales. T 110, L 68, F 90, S 8, H AV 3558, I/A 3 (27.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n