Buscador CIF Logo

Actos BORME Grant Thornton Advisory Slp

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Grant Thornton Advisory Slp

Actos BORME Grant Thornton Advisory Slp - B63120513

Tenemos registrados 57 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Grant Thornton Advisory Slp con CIF B63120513

馃敊 Perfil de Grant Thornton Advisory Slp
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Grant Thornton Advisory Slp

20 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ ROJAS FELIPE. Datos registrales. T 36651 , F 47, S 8, H M 657404, I/A 37 (13.12.23).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GARCIA RAUL. Datos registrales. T 36651 , F 48, S 8, H M 657404, I/A 38 (13.12.23).

13 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 36651 , F 47, S 8, H M 657404, I/A 36( 3.11.23).

25 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: VALERO FLORES FERNANDO. Datos registrales. T 36651 , F 44, S 8, H M 657404, I/A 30 (18.10.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: SANMARTIN ANTELO MANUEL. Datos registrales. T 36651 , F 44, S 8, H M 657404, I/A 31 (18.10.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA RAMOS MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 36651 , F 45, S 8, H M 657404, I/A 32(18.10.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: CARABA脩O MARI MARIO. Datos registrales. T 36651 , F 46, S 8, H M 657404, I/A 33 (18.10.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ DOMINGUEZ DANIEL. Datos registrales. T 36651 , F 46, S 8, H M 657404, I/A 34(18.10.23).

Revocaciones. Apoderado: PASTOR PEREZ FRANCISCO LUIS. Datos registrales. T 36651 , F 47, S 8, H M 657404, I/A 35(18.10.23).

28 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: CARDENAL RIVERA GERARDO. Datos registrales. T 36651 , F 43, S 8, H M 657404, I/A 29 (21.04.23).

18 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apoderado: MARIN BENITEZ IVANA INES. Datos registrales. T 36651 , F 41, S 8, H M 657404, I/A 26 (10.10.22).

Nombramientos. Apoderado: BUSTAMANTE AGUIRREBENGOA RAMON. Datos registrales. T 36651 , F 42, S 8, H M 657404, I/A27 (10.10.22).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CABALLERO JAVIER. Datos registrales. T 36651 , F 42, S 8, H M 657404, I/A 28(10.10.22).

10 de Octubre de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRANT THORNTON SLP. Representan: GALCERAN GUIM RAMON. Nombramientos. Adm.Unico: GRANT THORNTON CORPORACION SLP. Representan: GALCERAN GUIM RAMON. Ampliacion del objeto social. Laprestaci贸n de servicios de consultor铆a de negocio, riesgos y regulaci贸n, tecnolog铆a e innovaci贸n, dedicados a la mejora de la gesti贸n enlas compa帽铆as, que incluye el asesoramiento para el desarrollo y la evoluci贸n de la actividad comercial y la relaci贸n con clientes; laadaptaci贸n y ... Datos registrales. T 36651 , F 41, S 8, H M 657404, I/A 25 ( 3.10.22).

12 de Septiembre de 2022
Otros conceptos: SEGREGACION PARCIAL DE GRANT THORNTON SLP" DE LA ACTIVIDAD DE CONSULTORIA A FAVOR DE"GRANT THORNTON ADVISORY SLP" Y ESCISION PARCIAL A FAVOR DE "GRANT THORNTON CORPORACION SLP". Datosregistrales. T 36651 , F 40, S 8, H M 657404, I/A 24 ( 5.09.22).

07 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: PASTOR PEREZ FRANCISCO LUIS. Datos registrales. T 36651 , F 38, S 8, H M 657404, I/A 21(31.08.22).

Nombramientos. Apoderado: ROMANO MONTERO JAIME. Datos registrales. T 36651 , F 39, S 8, H M 657404, I/A 22 (31.08.22).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GRANT THORNTON CORPORACION SLP. Datos registrales. T36651 , F 40, S 8, H M 657404, I/A 23 (31.08.22).

18 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: NASSER WANDEMBERG JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 36651 , F 37, S 8, H M 657404,I/A 19 (11.07.22).

Nombramientos. Apoderado: BRAVO GARCIA ALFONSO. Datos registrales. T 36651 , F 38, S 8, H M 657404, I/A 20 (11.07.22).

13 de Julio de 2022
Nombramientos. Auditor: SENIOR MANAGER AUDITORS I CONSULTORS SL. Datos registrales. T 36651 , F 37, S 8, H M657404, I/A 18 ( 6.07.22).

26 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: ASENSIO RIVERO CARLOS. Datos registrales. T 36651 , F 35, S 8, H M 657404, I/A 16 (19.10.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: TARANCON DE UGARTE JORGE. Datos registrales. T 36651 , F 36, S 8, H M 657404, I/A 17(19.10.21).

11 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: D F ECONOMISTES AUDITORS SL. Datos registrales. T 36651 , F 35, S 8, H M 657404, I/A 15 ( 4.10.21).

29 de Mayo de 2020
Revocaciones. Apoderado: PONCE DE LEON RICOY ALFONSO;PONCE DE LEON RICOY ALFONSO. Datos registrales. T 36651, F 35, S 8, H M 657404, I/A 14 (23.05.20).

11 de Abril de 2019
Nombramientos. Auditor: D F ECONOMISTES AUDITORS SL. Datos registrales. T 36651 , F 34, S 8, H M 657404, I/A 13 (

09 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: CARDENAL RIVERA GERARDO. Datos registrales. T 36651 , F 34, S 8, H M 657404, I/A 12 (2.04.19).

11 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: GELLIDA BONET EDUARD. Datos registrales. T 36651 , F 33, S 8, H M 657404, I/A 11 ( 3.12.18).

14 de Noviembre de 2018
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 81 11 (MADRID). Datos registrales. T 36651 , F 33, S 8, H M 657404,I/A 10 ( 6.11.18).

20 de Julio de 2018
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ MARTIN ALEJANDRO. Datos registrales. T 36651 , F 32, S 8, H M 657404, I/A 7 (12.07.18).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ COSTEA MARTINEZ PABLO. Datos registrales. T 36651 , F 32, S 8, H M 657404, I/A 8(12.07.18).

Nombramientos. Apoderado: PONCE DE LEON RICOY ALFONSO. Datos registrales. T 36651 , F 33, S 8, H M 657404, I/A 9(12.07.18).

18 de Julio de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ CABALLERO JAVIER. Apo.Manc.: BELTRAN BUSTOS FERNANDO. Datosregistrales. T 36651 , F 31, S 8, H M 657404, I/A 6 (11.07.18).

17 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: TARANCON DE UGARTE JORGE. Datos registrales. T 36651 , F 31, S 8, H M 657404, I/A 5(10.07.18).

12 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: ASENSIO RIVERO CARLOS. Datos registrales. T 36651 , F 29, S 8, H M 657404, I/A 3 ( 5.07.18).

Nombramientos. Apoderado: LACASA CRISTINA FERNANDO. Datos registrales. T 36651 , F 30, S 8, H M 657404, I/A 4 (5.07.18).

27 de Noviembre de 2017
Cambio de domicilio social. C/ JOSE ABASCAL 56 (MADRID). Datos registrales. T 36651 , F 29, S 8, H M 657404, I/A 2(20.11.17).

23 de Octubre de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: CARDENAL RIVERA GERARDO. Datos registrales. T 45604 , F 75, S 8, H B 265754, I/A 33(16.10.17).

14 de Julio de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: BELTRAN BUSTOS FERNANDO. Datos registrales. T 45604 , F 74, S 8, H B 265754, I/A 32 (6.07.17).

07 de Junio de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: TARANCON DE UGARTE JORGE. Datos registrales. T 45604 , F 73, S 8, H B 265754, I/A 28(30.05.17).

Nombramientos. APODERAD.SOL: SANCHEZ MARTIN ALEJANDRO. Datos registrales. T 45604 , F 73, S 8, H B 265754, I/A 29(30.05.17).

Nombramientos. APODERAD.SOL: PONCE DE LEON RICOY ALFONSO. Datos registrales. T 45604 , F 73, S 8, H B 265754, I/A

Nombramientos. APODERAD.SOL: ASENSIO RIVERO CARLOS. Datos registrales. T 45604 , F 73, S 8, H B 265754, I/A 31(30.05.17).

18 de Abril de 2017
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: GONZALEZ CABALLERO JAVIER. Datos registrales. T 45604 , F 73, S 8, H B 265754, I/A 27 (6.04.17).

07 de Marzo de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: LACASA CRISTINA FERNANDO. Datos registrales. T 45604 , F 71, S 8, H B 265754, I/A 25(27.02.17).

Nombramientos. APODERAD.SOL: BELTRAN BUSTOS FERNANDO. Datos registrales. T 45604 , F 72, S 8, H B 265754, I/A 26(27.02.17).

01 de Diciembre de 2016
Revocaciones. REPR.143 RRM: FERNANDEZ ULLOA JOSE MARIA. Nombramientos. REPR.143 RRM: GALCERAN GUIMRAMON. Datos registrales. T 45604 , F 71, S 8, H B 265754, I/A 24 (23.11.16).

07 de Noviembre de 2016
Nombramientos. ADM.UNICO: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 45604 , F 71, S 8, H B 265754, I/A 23 (25.10.16).

13 de Octubre de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: LACASA CRISTINA FERNANDO. Datos registrales. T 41992 , F 120, S 8, H B 265754, I/A 22 (4.10.16).

11 de Julio de 2016
Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL Num.615 P.10 (BARCELONA). Datos registrales. T 41992 , F 120, S 8, H B 265754,I/A 21 (30.06.16).

09 de Mayo de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: LACASA CRISTINA FERNANDO. Datos registrales. T 41992 , F 119, S 8, H B 265754, I/A 20(29.04.16).

18 de Enero de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: GONZALEZ COSTEA MARTINEZ PABLO. Datos registrales. T 41992 , F 118, S 8, H B265754, I/A 18 ( 8.01.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: CARDENAL RIVERA GERARDO. Datos registrales. T 41992 , F 119, S 8, H B 265754, I/A 19 (8.01.16).

24 de Diciembre de 2015
Revocaciones. REPR.143 RRM: GOMEZ BERNAT EDUARDO. Nombramientos. REPR.143 RRM: FERNANDEZ ULLOA JOSEMARIA. Datos registrales. T 41992 , F 117, S 8, H B 265754, I/A 17 (15.12.15).

27 de Junio de 2013
Revocaciones. APODERADO: ESCANEZ RUIZ MARIA DEL MAR. Nombramientos. APODERAD.SOL: GONZALEZ COSTEAMARTINEZ PABLO. Datos registrales. T 41992 , F 117, S 8, H B 265754, I/A 16 (19.06.13).

14 de Junio de 2013
Nombramientos. APODERAD.SOL: BELTRAN BUSTOS FERNANDO. Datos registrales. T 41992 , F 116, S 8, H B 265754, I/A 15 (7.06.13).

26 de Septiembre de 2012
Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD,SOCIO UNICO:"GRANT THORNTON,S.L.P.". Datos registrales. T41992 , F 116, S 8, H B 265754, I/A 14 (18.09.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n