Buscador CIF Logo

Actos BORME Grant Thornton Slp

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Grant Thornton Slp

Actos BORME Grant Thornton Slp - B08914830

Tenemos registrados 109 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Grant Thornton Slp con CIF B08914830

馃敊 Perfil de Grant Thornton Slp
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Grant Thornton Slp

27 de Abril de 2023
Nombramientos. Apoderado: CARDENAL RIVERA GERARDO. Datos registrales. T 36652 , F 176, S 8, H M 657409, I/A 64(20.04.23).

01 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: GILABERT MOLIST AGUSTIN. Datos registrales. T 36652 , F 176, S 8, H M 657409, I/A 63 (25.01.23).

28 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apoderado: ROA USECHE JESUS DAVID. Datos registrales. T 36652 , F 175, S 8, H M 657409, I/A 61(21.10.22).

Nombramientos. Apoderado: MARIN BENITEZ IVANA INES. Datos registrales. T 36652 , F 176, S 8, H M 657409, I/A 62(21.10.22).

12 de Septiembre de 2022
Otros conceptos: SEGREGACION PARCIAL DE GRANT THORNTON SLP" DE LA ACTIVIDAD DE CONSULTORIA A FAVOR DE"GRANT THORNTON ADVISORY SLP" Y ESCISION PARCIAL A FAVOR DE "GRANT THORNTON CORPORACION SLP".Segregaci贸n. Beneficiarios de la segregaci贸n: GRANT THORNTON ADVISORY SLP. GRANT THORNTON CORPORACION SLP.Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: GRANT THORNTON ADVISORY SLP. GRANT THORNTONCORPORACION SLP. Datos registrales. T 36652 , F 171, S 8, H M 657409, I/A 60 ( 5.09.22).

13 de Julio de 2022
Nombramientos. Auditor: SENIOR MANAGER AUDITORS I CONSULTORS SL. Datos registrales. T 36652 , F 171, S 8, H M657409, I/A 59 ( 6.07.22).

10 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: TEJEDOR LOPEZ ANASTASI. Datos registrales. T 36652 , F 170, S 8, H M 657409, I/A 57 ( 3.02.22).

Revocaciones. Apoderado: CRUCES NAVARRO ALVARO;FERNANDEZ TRIVI脩O ESTEBAN. Datos registrales. T 36652 , F 171,S 8, H M 657409, I/A 58 ( 3.02.22).

27 de Diciembre de 2021
Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: INURE AUDIT SLP. Datos registrales. T 36652 , F 169, S 8, H M 657409,I/A 56 (20.12.21).

21 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ ALVARO. Datos registrales. T 36652 , F 168, S 8, H M 657409, I/A 55(14.10.21).

04 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: D F ECONOMISTES AUDITORS SL. Datos registrales. T 36652 , F 168, S 8, H M 657409, I/A 54 (27.09.21).

10 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: D F ECONOMISTES AUDITORS SL. Datos registrales. T 36652 , F 168, S 8, H M 657409, I/A 53 ( 3.03.21).

03 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ BORRELL ALEJANDRO. Datos registrales. T 36652 , F 168, S 8, H M 657409, I/A 52(24.02.21).

20 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Representan: MARTINEZ BORRELL ALEJANDRO. Nombramientos. Representan: SOLIGO ILLAMOLAGEMMA. Datos registrales. T 36652 , F 167, S 8, H M 657409, I/A 51 (13.11.20).

14 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apoderado: GALCERAN GUIM RAMON. Datos registrales. T 36652 , F 166, S 8, H M 657409, I/A 50 ( 6.10.20).

14 de Septiembre de 2020
Ampliacion del objeto social. La prestaci贸n de servicios de consultor铆a de negocio, riesgos y regulaci贸n, tecnolog铆a e innovaci贸n,dedicados a la mejora de la gesti贸n de las compa帽ias, que incluye el asesoramiento para el desarrollo y la evoluci贸n de la actividadcomercial y la relaci贸n con clientes. Datos registrales. T 36652 , F 166, S 8, H M 657409, I/A 49 ( 7.09.20).

05 de Agosto de 2020
Reelecciones. Auditor: D F ECONOMISTES AUDITORS SL. Datos registrales. T 36652 , F 165, S 8, H M 657409, I/A 48 (29.07.20).

26 de Mayo de 2020
Revocaciones. Apoderado: GARCIA-LOZANO GARCIA ANTONIO;GARCIA-LOZANO GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T36652 , F 165, S 8, H M 657409, I/A 47 (19.05.20).

05 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ APESTEGUIA JORGE. Datos registrales. T 36652 , F 164, S 8, H M 657409, I/A 46(27.02.20).

19 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ TRIVI脩O ESTEBAN. Datos registrales. T 36652 , F 164, S 8, H M 657409, I/A 45(12.12.19).

26 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apoderado: PEREZ GARCIA-RIPOLL JUAN RAMON;CAPELLA BRUGUERA CARLOS;MERELLO LAFUENTEPABLO;RADLEY-SEARLE DAVID-MICHAEL;ERA脩A ALEGRIA SANTIAGO;BAROJA TOQUERO FERNANDO;GURREA NICOLAUANDRES;MARTINEZ APESTEGUIA JORGE;VILLABONA DE LA FUENTE CARLOS;VALL GIL JUAN MARIA;SOLIGO ILLAMOLAGEMMA;LAZARO SERRANO MARIA JOSE;MIJAN LARRINAGA JUAN CARLOS;PUIG-SERRA CASAS SERGI;OLIUS BONSOMSYOLANDA;CONTELL GARCIA JOSE ENRIQUE;GONZALEZ DEL OLMO ALFREDO;GALCERAN GUIM RAMON. Apo.Sol.: GARCIA-LOZANO GARCIA ANTONIO;CRUCES NAVARRO ALVARO;GONZALEZ COSTEA MARTINEZ PABLO;CARDENAL RIVERAGERARDO;LOPEZ GARCIA JOSE MANUEL;GILABERT MOLIST AGUSTIN;PEREA GAVIRIA ISABEL;ALARCON ALEJANDRE

06 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apoderado: GARCIA-LOZANO GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 36652 , F 162, S 8, H M 657409, I/A 43(25.04.19).

11 de Abril de 2019
Reelecciones. Auditor: D F ECONOMISTES AUDITORS SL. Datos registrales. T 36652 , F 162, S 8, H M 657409, I/A 42 ( 4.04.19).

09 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ COSTEA MARTINEZ PABLO. Datos registrales. T 36652 , F 161, S 8, H M 657409, I/A39 ( 2.04.19).

Nombramientos. Apoderado: ARROJO LLERA BEGO脩A. Datos registrales. T 36652 , F 161, S 8, H M 657409, I/A 40 ( 2.04.19).

Nombramientos. Apoderado: CARDENAL RIVERA GERARDO. Datos registrales. T 36652 , F 162, S 8, H M 657409, I/A 41 (2.04.19).

14 de Noviembre de 2018
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 81 11 (MADRID). Datos registrales. T 36652 , F 159, S 8, H M 657409,I/A 36 ( 6.11.18).

Nombramientos. Apoderado: MARIN MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 36652 , F 159, S 8, H M 657409, I/A 37 ( 6.11.18).

Nombramientos. Apoderado: BARFALUY GARGALLO JOSE-MARIA. Datos registrales. T 36652 , F 160, S 8, H M 657409, I/A 38 (6.11.18).

02 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: PASTOR PEREZ FRANCISCO LUIS. Datos registrales. T 36652 , F 158, S 8, H M 657409, I/A 35(25.10.18).

08 de Marzo de 2018
Reelecciones. Auditor: D F ECONOMISTES AUDITORS SL. Datos registrales. T 36652 , F 157, S 8, H M 657409, I/A 34 (28.02.18).

23 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ COSTEA MARTINEZ PABLO. Datos registrales. T 36652 , F 153, S 8, H M 657409, I/A29 (15.02.18).

Nombramientos. Apoderado: GALCERAN GUIM RAMON. Datos registrales. T 36652 , F 154, S 8, H M 657409, I/A 30 (15.02.18).

Nombramientos. Apoderado: ERA脩A ALEGRIA SANTIAGO. Datos registrales. T 36652 , F 155, S 8, H M 657409, I/A 31(15.02.18).

Nombramientos. Apoderado: PUIG-SERRA CASAS SERGI. Datos registrales. T 36652 , F 156, S 8, H M 657409, I/A 32 (15.02.18).

Nombramientos. Apoderado: OLIUS BONSOMS YOLANDA. Datos registrales. T 36652 , F 157, S 8, H M 657409, I/A 33(15.02.18).

22 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: CAPELLA BRUGUERA CARLOS. Datos registrales. T 36652 , F 146, S 8, H M 657409, I/A 20(13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: VILLABONA DE LA FUENTE CARLOS. Datos registrales. T 36652 , F 147, S 8, H M 657409, I/A 21(13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: CONTELL GARCIA JOSE ENRIQUE. Datos registrales. T 36652 , F 148, S 8, H M 657409, I/A 22(13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: BAROJA TOQUERO FERNANDO. Datos registrales. T 36652 , F 149, S 8, H M 657409, I/A 23(13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: CARDENAL RIVERA GERARDO. Datos registrales. T 36652 , F 150, S 8, H M 657409, I/A 24

Nombramientos. Apoderado: PEREA GAVIRIA ISABEL. Datos registrales. T 36652 , F 151, S 8, H M 657409, I/A 25 (13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ APESTEGUIA JORGE. Datos registrales. T 36652 , F 151, S 8, H M 657409, I/A 26(13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 36652 , F 152, S 8, H M 657409, I/A 27(13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: SABORIT USO OSCAR. Datos registrales. T 36652 , F 153, S 8, H M 657409, I/A 28 (13.02.18).

20 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: SOLIGO ILLAMOLA GEMMA. Datos registrales. T 36652 , F 140, S 8, H M 657409, I/A 13 (13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: MIJAN LARRINAGA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 36652 , F 141, S 8, H M 657409, I/A 14(13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: VALL GIL JUAN MARIA. Datos registrales. T 36652 , F 142, S 8, H M 657409, I/A 15 (13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ GARCIA-RIPOLL JUAN RAMON. Datos registrales. T 36652 , F 142, S 8, H M 657409, I/A 16(13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: GILABERT MOLIST AGUSTIN. Datos registrales. T 36652 , F 143, S 8, H M 657409, I/A 17(13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: CRUCES NAVARRO ALVARO. Datos registrales. T 36652 , F 144, S 8, H M 657409, I/A 18(13.02.18).

Nombramientos. Apoderado: GURREA NICOLAU ANDRES. Datos registrales. T 36652 , F 145, S 8, H M 657409, I/A 19(13.02.18).

19 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: CARO JIMENEZ MANUEL. Datos registrales. T 36652 , F 140, S 8, H M 657409, I/A 12 (11.12.17).

11 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ ULLOA JOSE MARIA;CIRIACO FERNANDEZ ALFREDO;CIRIACO FERNANDEZ ALFREDO.Datos registrales. T 36652 , F 140, S 8, H M 657409, I/A 11 (30.11.17).

30 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: LAZARO SERRANO MARIA JOSE. Datos registrales. T 36652 , F 133, S 8, H M 657409, I/A 3(23.11.17).

Nombramientos. Apoderado: RADLEY-SEARLE DAVID-MICHAEL. Datos registrales. T 36652 , F 134, S 8, H M 657409, I/A 4(23.11.17).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ARAMENDI I脩IGO DE LOYOLA. Datos registrales. T 36652 , F 135, S 8, H M 657409, I/A5 (23.11.17).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA-LOZANO GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 36652 , F 136, S 8, H M 657409, I/A 6(23.11.17).

Nombramientos. Apoderado: ROMANO MONTERO JAIME. Datos registrales. T 36652 , F 137, S 8, H M 657409, I/A 7 (23.11.17).

Nombramientos. Apoderado: ALARCON ALEJANDRE MARTA. Datos registrales. T 36652 , F 138, S 8, H M 657409, I/A 8(23.11.17).

Nombramientos. Apoderado: CALZADA CRIADO DAVID. Datos registrales. T 36652 , F 138, S 8, H M 657409, I/A 9 (23.11.17).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DEL OLMO ALFREDO. Datos registrales. T 36652 , F 139, S 8, H M 657409, I/A 10(23.11.17).

28 de Noviembre de 2017
Cambio de domicilio social. C/ JOSE ABASCAL 56 (MADRID). Datos registrales. T 36652 , F 133, S 8, H M 657409, I/A 2(21.11.17).

20 de Julio de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: CALZADA CRIADO DAVID. Datos registrales. T 45847 , F 112, S 8, H B 12635, I/A 171(12.07.17).

11 de Julio de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: BELTRAN BUSTOS FERNANDO. Datos registrales. T 45847 , F 111, S 8, H B 12635, I/A 170 (3.07.17).

10 de Abril de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: MERELLO LAFUENTE PABLO. Datos registrales. T 42976 , F 225, S 8, H B 12635, I/A 169(31.03.17).

27 de Marzo de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DF ECONOMISTES AUDITORS SLP. Datos registrales. T 42976 , F 225, S 8, H B 12635, I/A168 (17.03.17).

05 de Enero de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: DAVID MICHAEL RADLEY SEARLE. Datos registrales. T 43976 , F 222, S 8, H B 12635, I/A164 (28.12.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: VILLABONA DE LA FUENTE CARLOS. Datos registrales. T 42976 , F 223, S 8, H B 12635, I/A165 (28.12.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: LAZARO SERRANO MARIA JOSE. Datos registrales. T 42976 , F 224, S 8, H B 12635, I/A 166(28.12.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: CIRIACO FERNANDEZ ALFREDO. Datos registrales. T 42976 , F 225, S 8, H B 12635, I/A 167(28.12.16).

27 de Diciembre de 2016
Revocaciones. APODERADO: CARDENAL RIVERA GERARDO;CIRIACO FERNANDEZ ALFREDO;GOMEZ BERNATEDUARDO;FERNANDEZ ULLOA JOSE MARIA;CIRIACO FERNANDEZ ALFREDO. APODERAD.SOL: CARDENAL RIVERAGERARD. APODERADO: GONZALEZ COSTEA MARTINEZ PABLO. APODERAD.SOL: CARDENAL RIVERA GERARDO;CIRIACOFERNANDEZ ALFREDO. Nombramientos. APODERAD.SOL: FERNANDEZ ULLOA JOSE MARIA;CIRIACO FERNANDEZALFREDO. Datos registrales. T 42976 , F 221, S 8, H B 12635, I/A 163 (16.12.16).

02 de Diciembre de 2016
Revocaciones. REPR.143 RRM: FERNANDEZ ULLOA JOSE MARIA. Nombramientos. REPR.143 RRM: MARTINEZ BORRELLALEJANDRO. Datos registrales. T 42976 , F 221, S 8, H B 12635, I/A 162 (24.11.16).

07 de Noviembre de 2016
Nombramientos. ADM.UNICO: GRANT THORNTON CORPORACION SLP. Datos registrales. T 42976 , F 221, S 8, H B 12635, I/A161 (25.10.16).

17 de Octubre de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: CARO JIMENEZ MANUEL. Datos registrales. T 42976 , F 220, S 8, H B 12635, I/A 160 (4.10.16).

11 de Julio de 2016
Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL Num.615 P.10 (BARCELONA). Datos registrales. T 42976 , F 220, S 8, H B 12635, I/A159 (30.06.16).

26 de Mayo de 2016
Revocaciones. APODERADO: FERNANDEZ DE CASTILLO Y VALDERRAMA PEDRO MARIA;VERDU PASCUAL RAFAEL. Datosregistrales. T 42976 , F 219, S 8, H B 12635, I/A 157 (19.05.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: CIRIACO FERNANDEZ ALFREDO. Datos registrales. T 42976 , F 219, S 8, H B 12635, I/A 158(19.05.16).

26 de Febrero de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: ALARCON ALEJANDRE MARTA. Datos registrales. T 42976 , F 219, S 8, H B 12635, I/A 156(18.02.16).

24 de Febrero de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DF ECONOMISTES AUDITORS SL. Datos registrales. T 42976 , F 218, S 8, H B 12635, I/A 155(15.02.16).

18 de Enero de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: GONZALEZ COSTEA MARTINEZ PABLO. Datos registrales. T 42976 , F 215, S 8, H B 12635,I/A 148 (11.01.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: SABORIT USO OSCAR. Datos registrales. T 42976 , F 216, S 8, H B 12635, I/A 149(11.01.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: CARDENAL RIVERA GERARDO. Datos registrales. T 42976 , F 217, S 8, H B 12635, I/A 150(11.01.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: LOPEZ GARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 42976 , F 217, S 8, H B 12635, I/A 151(11.01.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: GILABERT MOLIST AGUSTIN. Datos registrales. T 42976 , F 218, S 8, H B 12635, I/A 152(11.01.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: PEREA GAVIRIA ISABEL. Datos registrales. T 42976 , F 218, S 8, H B 12635, I/A 153(11.01.16).

Revocaciones. APODERADO: MORENO GONZALEZ DONATO;CAMINS MOCHALES FRANCISCO;GONZALEZ LOSANTOSSARA;DE SOPE脩A FERNANDEZ IGNACIO. Datos registrales. T 42976 , F 218, S 8, H B 12635, I/A 154 (11.01.16).

24 de Diciembre de 2015
Revocaciones. REPR.143 RRM: GOMEZ BERNAT EDUARDO. Nombramientos. REPR.143 RRM: FERNANDEZ ULLOA JOSEMARIA. Datos registrales. T 42976 , F 215, S 8, H B 12635, I/A 147 (15.12.15).

01 de Abril de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DF ECONOMISTAS AUDITORS SL. Datos registrales. T 42976 , F 215, S 8, H B 12635, I/A 146(24.03.15).

18 de Julio de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: GARCIA LOZANO GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 42976 , F 213, S 8, H B 12635, I/A142 (10.07.14).

Revocaciones. APODERADO: ESCANEZ RUIZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 42976 , F 213, S 8, H B 12635, I/A 143(10.07.14).

Nombramientos. APODERAD.SOL: CRUCES NAVARRO ALVARO. Datos registrales. T 42976 , F 214, S 8, H B 12635, I/A 144(10.07.14).

Nombramientos. APODERAD.SOL: CARDENAL RIVERA GERARDO. Datos registrales. T 42976 , F 214, S 8, H B 12635, I/A 145

23 de Abril de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DF ECONOMISTES AUDITORS SL. Datos registrales. T 42976 , F 213, S 8, H B 12635, I/A 141(11.04.14).

31 de Marzo de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: CARDENAL RIVERA GERARD. Datos registrales. T 42976 , F 212, S 8, H B 12635, I/A 140(20.03.14).

18 de Julio de 2012
Fe de erratas: En el BORME no.233/2011 y con referencia 491309 SE OMITIO CONSIGNAR LA CONVERSION EN SOCIEDADUNIPERSONAL,SIENDO SU UNICO SOCIO: GRANT THORNTON CORPORACION SLP. Datos registrales. T 41840 , F 145, S 8, HB 12635, I/A 133 (29.11.11).

10 de Mayo de 2012
Nombramientos. APODERADO: DE SOPE脩A FERNANDEZ IGNACIO. Datos registrales. T 42976 , F 212, S 8, H B 12635, I/A 139(26.04.12).

26 de Enero de 2012
Nombramientos. APODERADO: GALCERAN GUIM RAMON. Datos registrales. T 41840 , F 150, S 8, H B 12635, I/A 135(13.01.12).

Revocaciones. APODERADO: MARCO GRANELL JUAN ALBERTO;SAN SEGUNDO ONTIN AUGUSTO. Datos registrales. T41840 , F 150, S 8, H B 12635, I/A 136 (13.01.12).

Nombramientos. APODERADO: GONZALEZ COSTEA MARTINEZ PABLO. Datos registrales. T 42976 , F 211, S 8, H B 12635, I/A137 (13.01.12).

Nombramientos. APODERADO: GONZALEZ LOSANTOS SARA. Datos registrales. T 42976 , F 212, S 8, H B 12635, I/A 138(13.01.12).

12 de Diciembre de 2011
Otros conceptos: SEPARACION DE LOS SOCIOS PROFESIONALES EDUARDO GOMEZ BERNAT,DONATO MORENOGONZALEZ,ALEJANDRO MARTINEZ BORRELL,JOSE MARIA FERNANDEZ ULLOA,JUAN ALBERTO MARCOGRANELL,AUGUSTO SAN SEGUNDO ONTIN,FRANCISCO DE PAULA BENEDE LUGANY,CARLOS CAPELLA

Revocaciones. MRO.COMS.EJE: GOMEZ BERNAT EDUARDO;MARTINEZ BORRELL ALEJANDRO;FERNANDEZ ULLOA JOSEMARIA. CONSEJERO: MORENO GONZALEZ DONATO. SECRETARIO: MORENO GONZALEZ DONATO. CONSEJERO: GOMEZBERNAT EDUARDO;FERNANDEZ ULLOA JOSE MARIA;MARTINEZ BORRELL ALEJANDRO. PRESIDENTE: GOMEZ BERNATEDUARDO. Nombramientos. ADM.UNICO: GRANT THORNTON CORPORACION SLP. REPR.143 RRM: GOMEZ BERNATEDUARDO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de objetosocial. EL EJERCICIO EN COMUN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES CONSISTENTES EN:LA PRESTACION DESERVICIOS DE AUDITORIA DE CUENTAS,CONSISTENTES EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS,INFORMES Y DICTAMENESRELACIONADOS CON EL EXAMEN DE ... Datos registrales. T 41840 , F 145, S 8, H B 12635, I/A 134 (29.11.11).

13 de Junio de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DF ECONOMISTAS AUDITORS SL. Datos registrales. T 41840 , F 145, S 8, H B 12635, I/A 132 (1.06.11).

12 de Abril de 2011
Nombramientos. APODERADO: GONZALEZ DEL OLMO ALFREDO. Datos registrales. T 41840 , F 144, S 8, H B 12635, I/A 131 (1.04.11).

04 de Abril de 2011
Otros conceptos: ADMISION DE JOSE ENRIQUE CONTELL GARCIA COMO NUEVO SOCIO PROFESIONAL Y CONSECUENTESCAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 41840 , F 144, S 8, H B 12635, I/A130 (22.03.11).

21 de Enero de 2011
Otros conceptos: CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES A LOS SOCIOS PROFESIONALES.Datos registrales. T 41840 , F 143, S 8, H B 12635, I/A 128 (11.01.11).

Otros conceptos: CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES A LOS SOCIOS PROFESIONALES YPERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO PROFESIONAL DE FRANCISCO CAMINS MOCHALES. Datos registrales. T 41840 , F143, S 8, H B 12635, I/A 129 (11.01.11).

30 de Diciembre de 2010
Nombramientos. APODERADO: CONTELL GARCIA JOSE ENRIQUE. Datos registrales. T 41840 , F 142, S 8, H B 12635, I/A 127(21.12.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n