Buscador CIF Logo

Actos BORME Graphenano Composites Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Graphenano Composites Sl

Actos BORME Graphenano Composites Sl - B87327847

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Graphenano Composites Sl con CIF B87327847

馃敊 Perfil de Graphenano Composites Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Graphenano Composites Sl

23 de Marzo de 2023
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRAPHENANO S.L. Nombramientos. Cons.: MARTIN MARTINEZ ROVIRA;JOSE-ANTONIO MARTINEZ ROVIRA. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.474.662,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.977.662,00 Euros.Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.977.662,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:525.338,00 Euros. Resultante Suscrito: 525.338,00 Euros. Datos registrales. T 3507 , F 38, S 8, H MU104762, I/A 6 (15.03.23).

05 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRANCISCO JAVIER NAVARRO GARCIA;GRAPHENDIS SL. Cons.Del.Man: FRANCISCO JAVIERNAVARRO GARCIA. Datos registrales. T 3507 , F 36, S 8, H MU104762, I/A 5 (30.12.22).

30 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: ZAIDA SORIA MOMPO. Datos registrales. T 3507 , F 36, S 8, H MU104762, I/A 3 (23.04.21).

Nombramientos. Apoderado: JOSE ANTONIO MARTINEZ ROVIRA. Datos registrales. T 3507 , F 36, S 8, H MU104762, I/A 4(23.04.21).

23 de Abril de 2021
Cambio de domicilio social. C/ PABLO CASALS, N潞 13, BAJO (YECLA). Datos registrales. T 3507 , F 35, S 8, H MU104762, I/A 2(16.04.21).

12 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERROCAL ROSIQUE ANTONIO RAFAEL. Cons.Del.Man: BERROCAL ROSIQUE ANTONIORAFAEL. Nombramientos. Consejero: GRAPHENDIS SL. Datos registrales. T 39357 , F 1, S 8, H M 611832, I/A 9 ( 8.02.21).

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: BLASCO ALVENTOSA ENRIQUE. Nombramientos. Secretario: 206 WORKS SL. Representan:MARTINEZ ROVIRA JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 39357 , F 1, S 8, H M 611832, I/A 10 ( 8.02.21).

Ceses/Dimisiones. Secretario: 206 WORKS SL. Representan: MARTINEZ ROVIRA JOSE-ANTONIO. Nombramientos.SecreNoConsj: BRIONES BORI LUIS. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 11, 13 Y 21 DE LOSESTATUTOS.. Datos registrales. T 39357 , F 2, S 8, H M 611832, I/A 11 ( 8.02.21).

27 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: RESUSTA COVARRUBIAS I脩IGO;ZARZA COVERTIC SL. Vicepresid.: RESUSTA COVARRUBIASI脩IGO. Cons.Del.Man: RESUSTA COVARRUBIAS I脩IGO. Secretario: ZARZA COVERTIC SL. Cons.Del.Man: ZARZA COVERTIC SL.Datos registrales. T 33998 , F 143, S 8, H M 611832, I/A 8 (20.06.19).

30 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: CELDRAN ROMERO MARIO;MARTINEZ ROVIRA MARTIN;ZARZA GARCIA ALVARO. Presidente:MARTINEZ ROVIRA MARTIN. Secretario: ZARZA GARCIA ALVARO. Cons.Del.Man: MARTINEZ ROVIRA MARTIN;CELDRANROMERO MARIO;ZARZA GARCIA ALVARO. Vicepresid.: CELDRAN ROMERO MARIO. Cons.Del.Man: NAVARRO GARCIAFRANCISCO JAVIER;BERROCAL ROSIQUE ANTONIO RAFAEL;RESUSTA COVARRUBIAS I脩IGO. Revocaciones. Apo.Sol.:VIEJO MADRAZO MIGUEL. Apoderado: BIGERIEGO DE HINOJOSA DIEGO. Nombramientos. VsecrNoConsj: BLASCOALVENTOSA ENRIQUE. Consejero: TINMAR 1973 SL;ZARZA COVERTIC SL;206 WORKS SL. Presidente: TINMAR 1973 SL.Vicepresid.: RESUSTA COVARRUBIAS I脩IGO. Secretario: ZARZA COVERTIC SL. Cons.Del.Man: RESUSTA COVARRUBIASI脩IGO;ZARZA COVERTIC SL;TINMAR 1973 SL;206 WORKS SL;BERROCAL ROSIQUE ANTONIO RAFAEL;NAVARRO GARCIAFRANCISCO JAVIER. Representan: MARTINEZ ROVIRA MARTIN;ZARZA GARCIA ALVARO;MARTINEZ ROVIRA JOSE-ANTONIO.Datos registrales. T 33998 , F 142, S 8, H M 611832, I/A 7 (23.11.18).

26 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: BERROCAL ROSIQUE ANTONIO RAFAEL. Datos registrales. T 33998 , F 141, S 8, H M 611832, I/A6 (16.02.18).

10 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apoderado: BIGERIEGO DE HINOJOSA DIEGO. Datos registrales. T 33998 , F 141, S 8, H M 611832, I/A 5 (2.08.16).

08 de Abril de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 503.000,00 Euros. Datos registrales. T 33998 , F 140, S 8,H M 611832, I/A 4 (31.03.16).

06 de Abril de 2016
Nombramientos. Vicepresid.: CELDRAN ROMERO MARIO. Datos registrales. T 33998 , F 140, S 8, H M 611832, I/A 3 (29.03.16).

15 de Enero de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: VIEJO MADRAZO MIGUEL. Datos registrales. T 33998 , F 138, S 8, H M 611832, I/A 2 ( 8.01.16).

10 de Noviembre de 2015
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 26.06.15. Objeto social: a).- La Investigaci贸n, fabricaci贸n, desarrollo distribuci贸n,comercializaci贸n e intermediaci贸n en la comercializaci贸n, tanto en Espa帽a como en el extranjero, de grafeno u otros componentesnanotecnol贸gicos derivados delgrafeno, en cualquiera de sus formas, as铆 como de cualquier tipo de productos... Domicilio: C/SERRANO 67 2& (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: CELDRAN ROMERO MARIO;MARTINEZROVIRA MARTIN;RESUSTA COVARRUBIAS I脩IGO;ZARZA GARCIA ALVARO;NAVARRO GARCIA FRANCISCOJAVIER;BERROCAL ROSIQUE ANTONIO RAFAEL. Presidente: MARTINEZ ROVIRA MARTIN. Secretario: ZARZA GARCIA ALVARO.Cons.Del.Man: MARTINEZ ROVIRA MARTIN;CELDRAN ROMERO MARIO;NAVARRO GARCIA FRANCISCO JAVIER;BERROCALROSIQUE ANTONIO RAFAEL;RESUSTA COVARRUBIAS I脩IGO;ZARZA GARCIA ALVARO. Datos registrales. T 33998 , F 133, S 8,H M 611832, I/A 1 ( 2.11.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n