Actos BORME de Gras Savoye Iberica Sa
26 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SOULIER BERNARD;GARCIA MARTIN RUBEN;SERRATS IRIARTE ANTONIO SALVADOR;GARCIAMARTIN RUBEN. Presidente: GARCIA MARTIN RUBEN. Secretario: MARTINEZ FRESNEDA ORTIZ DE SOLORZANO JUANCARLOS. Revocaciones. Apoderado: COLOMBO FRANCOIS;DE LA PE脩A RODRIGUEZ FELIX;CARTOZO ALEJANDRO. Apo.Sol.:MIGUEL CASTRO EDUARDO;GARCIA MARTIN RUBEN. Nombramientos. Liquidador: GARCIA MARTIN RUBEN. Disoluci贸n.Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 23203 , F 210, S 8, H M 87103, I/A 32 (19.03.19).
01 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GARCIA MARTIN RUBEN. Presidente: LUCAS PATRICK. Consejero: LUCAS PATRICK.Nombramientos. Consejero: SERRATS IRIARTE ANTONIO SALVADOR;GARCIA MARTIN RUBEN. Presidente: GARCIA MARTINRUBEN. Datos registrales. T 23203 , F 209, S 8, H M 87103, I/A 31 (24.08.17).
19 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: COLOMBO FRANCOIS. Consejero: COLOMBO FRANCOIS. Con.Delegado: COLOMBO FRANCOIS.Nombramientos. Vicepresid.: GARCIA MARTIN RUBEN. Reelecciones. Consejero: SOULIER BERNARD;GARCIA MARTINRUBEN. Presidente: LUCAS PATRICK. Consejero: LUCAS PATRICK. Datos registrales. T 23203 , F 209, S 8, H M 87103, I/A 30 (7.12.16).
26 de Octubre de 2012Cambio de domicilio social. C/ BOCANGEL, 38 1& (MADRID). Datos registrales. T 23203 , F 209, S 8, H M 87103, I/A 29(16.10.12).
30 de Mayo de 2011Revocaciones. Apoderado: GARCIA MARTIN RUBEN;MIGUEL CASTRO EDUARDO. Datos registrales. T 23203 , F 207, S 8, H M87103, I/A 26 (19.05.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: MIGUEL CASTRO EDUARDO. Datos registrales. T 23203 , F 207, S 8, H M 87103, I/A 27 (19.05.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MARTIN RUBEN. Datos registrales. T 23203 , F 208, S 8, H M 87103, I/A 28 (19.05.11).