Actos BORME de Greymo Sa
26 de Julio de 2023Reelecciones. Consejero: JIMENEZ GARCIA RAUL;JIMENEZ ALVAREZ CARLOS;TULLA ECHEVARRIA ALFONSO EZEQUIEL.Con.Delegado: JIMENEZ GARCIA RAUL. Presidente: JIMENEZ GARCIA RAUL. Secretario: TULLA ECHEVARRIA ALFONSOEZEQUIEL. Datos registrales. T 38092 , F 62, S 8, H M 89267, I/A 19 (19.07.23).
10 de Junio de 2020Cambio de domicilio social. C/ MARCONI 9 (DAGANZO DE ARRIBA). Datos registrales. T 38092 , F 62, S 8, H M 89267, I/A 18 (3.06.20).
18 de Febrero de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 73.562,40 Euros. Desembolsado: 73.562,40 Euros. Resultante Suscrito: 170.383,50 Euros.Resultante Desembolsado: 170.383,50 Euros. Datos registrales. T 38092 , F 61, S 8, H M 89267, I/A 17 (11.02.19).
27 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ ALVAREZ CARLOS. Datos registrales. T 38092 , F 61, S 8, H M 89267, I/A 16 (19.12.18).
05 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ CAMPO SABINO;JIMENEZ GARCIA RAUL. Presidente: JIMENEZ CAMPO SABINO.Vicepresid.: JIMENEZ GARCIA RAUL. Secretario: TULLA ECHEVARRIA ALFONSO EZEQUIEL. Consejero: TULLA ECHEVARRIAALFONSO EZEQUIEL. Con.Delegado: JIMENEZ GARCIA RAUL. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ GARCIA RAUL;JIMENEZALVAREZ CARLOS;TULLA ECHEVARRIA ALFONSO EZEQUIEL. Con.Delegado: JIMENEZ GARCIA RAUL. Presidente: JIMENEZGARCIA RAUL. Secretario: TULLA ECHEVARRIA ALFONSO EZEQUIEL. Datos registrales. T 5455 , F 144, S 8, H M 89267, I/A 15(28.11.18).
22 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: JIMENEZ CAMPO SABINO;JIMENEZ GARCIA RAUL. Nombramientos. Con.Delegado:JIMENEZ GARCIA RAUL. Datos registrales. T 5455 , F 144, S 8, H M 89267, I/A 14 (12.01.18).
20 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ CAMPO SABINO. Presidente: JIMENEZ CAMPO SABINO. Consejero: MARISCALARROYO ESTHER. Secretario: MARISCAL ARROYO ESTHER. Consejero: TULLA ECHEVARRIA ALFONSO EZEQUIEL.Con.Delegado: JIMENEZ CAMPO SABINO. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ CAMPO SABINO;JIMENEZ GARCIA RAUL.
12 de Agosto de 2013Nombramientos. Apoderado: MARISCAL ARROYO ESTHER. Datos registrales. T 5455 , F 143, S 8, H M 89267, I/A 12 (29.07.13).
06 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ CAMPO SABINO. Presidente: JIMENEZ CAMPO SABINO. Con.Delegado: JIMENEZCAMPO SABINO. Consejero: MARISCAL ARROYO ESTHER. Secretario: MARISCAL ARROYO ESTHER. Consejero: TULLAECHEVARRIA ALFONSO. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ CAMPO SABINO. Presidente: JIMENEZ CAMPO SABINO.Consejero: MARISCAL ARROYO ESTHER. Secretario: MARISCAL ARROYO ESTHER. Consejero: TULLA ECHEVARRIA ALFONSOEZEQUIEL. Con.Delegado: JIMENEZ CAMPO SABINO. Datos registrales. T 5455 , F 143, S 8, H M 89267, I/A 11 (26.06.12).
19 de Enero de 2010Nombramientos. Auditor: CUSPIDE AUDITORES SL. Datos registrales. T 5455 , F 142, S 8, H M 89267, I/A 10 ( 7.01.10).
02 de Marzo de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 11.361,07 Euros. Resultante Suscrito: 96.821,11 Euros. Datos registrales. T 5455 , F 141,S 8, H M 89267, I/A 9 (18.02.09).
08 de Enero de 2009Nombramientos. Auditor: CUSPIDE AUDITORES SL. Datos registrales. T 5455 , F 141, S 8, H M 89267, I/A 8 (23.12.08).