Buscador CIF Logo

Actos BORME Grg Consultoria Hipotecaria Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Grg Consultoria Hipotecaria Sl

Actos BORME Grg Consultoria Hipotecaria Sl - B16888067

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Grg Consultoria Hipotecaria Sl con CIF B16888067

馃敊 Perfil de Grg Consultoria Hipotecaria Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Grg Consultoria Hipotecaria Sl

19 de Junio de 2023
Nombramientos. Apoderado: LINARES COBO MARIA;HERRERO SOMOLINOS CARLOS SANTIAGO;NAVARRO RAMONMARIA;GARCIA ACAL DARIO MIGUEL. Datos registrales. T 42497 , F 57, S 8, H M 751950, I/A 11 (12.06.23).

Nombramientos. Apoderado: LINARES COBO MARIA. Datos registrales. T 42497 , F 58, S 8, H M 751950, I/A 12 (12.06.23).

27 de Abril de 2023
Nombramientos. Apoderado: GUADA脩O MONTERO ROBERTO;LINARES COBO IVAN;ALVAREZ CARABIAS JOSEMANUEL;GALA RODRIGO RAQUEL;RODRIGUEZ VEGA ADRIAN;CEBRIAN RIVERA NOELIA;MERINO PEREZ VIRGINIA;AYUSOPALOMO SARA;BOUSO DIAZ OLALLA;SOMAGOSO ARIAS LAURA TERESA;PLANA LUENGO JOSE ANTONIO. Datos registrales.T 42497 , F 57, S 8, H M 751950, I/A 10 (20.04.23).

20 de Abril de 2023
Nombramientos. Apoderado: HERRERO SOMOLINOS ALEJANDRO. Datos registrales. T 42497 , F 56, S 8, H M 751950, I/A 9

17 de Abril de 2023
Nombramientos. Apoderado: MERINO PEREZ VIRGINIA. Datos registrales. T 42497 , F 56, S 8, H M 751950, I/A 8 (10.04.23).

06 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ CORRO ALVARO TOMAS;BERNAL JIMENEZ GERMAN. Apo.Sol.: CERRATO NOGALESPATRICIA;PRESENCIO SERRANO MARIA SOLEDAD. Datos registrales. T 42497 , F 56, S 8, H M 751950, I/A 7 (27.02.23).

20 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: SIERRA ORTIZ JOSE MARIA. Apo.Sol.: PRESENCIO SERRANO SONIA. Datos registrales. T 42497 ,F 55, S 8, H M 751950, I/A 6 (13.02.23).

27 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ACAL DARIO MIGUEL;SALAZAR GIL FRANCISCO JAVIER;VILLANUEVA SANCHEZ JOSEANTONIO;MONTORO GUIJARRO MARIA OLGA;ARMIJO BIDON PABLO. Datos registrales. T 42497 , F 55, S 8, H M 751950, I/A 5(19.12.22).

11 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: CERRATO NOGALES PATRICIA;PRESENCIO SERRANO MARIA SOLEDAD;PRESENCIO SERRANOSONIA Datos registrales. T 42497 , F 54, S 8, H M 751950, I/A 4 ( 4.10.22).

16 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: CRUCERA BERNAL FRANCISCO;PRIETO HERRAEZ SERGIO. Datos registrales. T 42497 , F 53, S8, H M 751950, I/A 3 ( 9.09.22).

14 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: GARCIA DIAZ CANO ANA;ESPINOZA SANTILLAN LUIS FELIPE;ENCINA GONZALEZ ALEJANDRORICARDO;SIERRA ORTIZ JOSE MARIA;HERNANDEZ CORRO ALVARO TOMAS;BERNAL JIMENEZ GERMAN;HERREROSOMOLINOS ALEJANDRO. Datos registrales. T 42497 , F 52, S 8, H M 751950, I/A 2 ( 7.07.22).

06 de Octubre de 2021
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 14.09.21. Objeto social: a) La prestaci贸n de servicios auxiliares de empresa, concretamente

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n