Actos BORME de Gromeron Sl
26 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE LUIS. Representan: YOUSFAN MORENO RIMA. Consejero: DEABIEGA PONS SANTIAGO;GUICHARD GONZALEZ GRACIANO FRANCISCO. Presidente: GUICHARD GONZALEZ GRACIANOFRANCISCO. Consejero: BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL. Revocaciones. Apoderado: DE ABIEGA PONSSANTIAGO;BIDAGUREN URBIETA MIREN;ELIAS MARTIN CRISTINA;SALAMANCA CARRASCO VICTOR MARCELINO;GUICHARDGONZALEZ GRACIANO FRANCISCO. Otros conceptos: Que ha quedado el 22/06/2023, inscrita la sociedad en el Registro P煤blicode Comercio de la Ciudad de M茅xico, con la denominaci贸n GOMERON SRL DE CAPITAL VARIABLE. Datos de inscripci贸nNCI202300157416. Extinci贸n. Datos registrales. T 28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/A 16 (18.12.23).
05 de Mayo de 2023Otros conceptos: Se acuerda el traslado de domicilio internacional, a Prol Vasco de Quiroga No. 4800 Torre 2, Piso 3, Colonia SantaFe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de M茅xico, Estados Unidos Mexicanos (M茅xico). Datos registrales. T28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/ACIERR (26.04.23).
15 de Febrero de 2023P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/A 15 ( 8.02.23).
07 de Diciembre de 2022Otros conceptos: Proyecto de traslado del domicilio social a Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de M茅xico, Estados Unicos Mexicanos(M茅xico).- Datos registrales. T 28007 , F 132, S 8, H M 504743, I/A 1M (29.11.22).
11 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA. Representan: SALAMANCA CARRASCO VICTORMARCELINO. Nombramientos. Consejero: BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL. Representan: YOUSFAN MORENO RIMA.Datos registrales. T 28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/A 14 ( 4.03.22).
12 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: GUICHARD GONZALEZGRACIANO FRANCISCO. Datos registrales. T 28007 , F 190, S 8, H M 504743, I/A 12 ( 5.08.19).
Cambio de domicilio social. C/ NANCLARES DE OCA, NUMERO 1B (MADRID). Datos registrales. T 28007 , F 191, S 8, H M504743, I/A 13 ( 5.08.19).
12 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Secretario: FERNANDEZ MARTIN PEDRO. Nombramientos. SecreNoConsj: RODRIGUEZ JIMENEZ JOSELUIS. Datos registrales. T 28007 , F 190, S 8, H M 504743, I/A 11 ( 5.04.19).
11 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO. Presidente: SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO.Nombramientos. Consejero: GUICHARD GONZALEZ GRACIANO FRANCISCO. Presidente: GUICHARD GONZALEZ GRACIANOFRANCISCO. Datos registrales. T 28007 , F 189, S 8, H M 504743, I/A 10 ( 4.04.19).
17 de Febrero de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 830.734,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.412.488,00 Euros. Datos registrales. T 28007 ,F 188, S 8, H M 504743, I/A 9 ( 7.02.12).
07 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: SALAMANCA CARRASCO VICTOR MARCELINO. Nombramientos. Apoderado: SALAMANCACARRASCO VICTOR MARCELINO. Datos registrales. T 28007 , F 138, S 8, H M 504743, I/A 8 (26.01.12).
15 de Diciembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 30.239.922,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.243.222,00 Euros. Datos registrales. T 28007 , F 138,S 8, H M 504743, I/A 7 ( 1.12.11).
26 de Octubre de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CORPORACION GROMERON SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALV. Datos registrales. T 28007 , F 138, S 8, H M 504743, I/A 6 (13.10.11).
14 de Julio de 2011Nombramientos. Apoderado: SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO;DE ABIEGA PONS SANTIAGO. Datos registrales. T 28007, F 134, S 8, H M 504743, I/A 3 ( 4.07.11).
Nombramientos. Apoderado: BIDAGUREN URBIETA MIREN;ELIAS MARTIN CRISTINA. Datos registrales. T 28007 , F 136, S 8, HM 504743, I/A 4 ( 4.07.11).
Nombramientos. Apoderado: SALAMANCA CARRASCO VICTOR MARCELINO. Datos registrales. T 28007 , F 136, S 8, H M504743, I/A 5 ( 4.07.11).
12 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ATALAYA SEVILLANO MARIA TERESA. Nombramientos. Representan: SALAMANCACARRASCO VICTOR MARCELINO. Secretario: FERNANDEZ MARTIN PEDRO. Consejero: SALGADO MARTINEZ JORGEANTONIO;DE ABIEGA PONS SANTIAGO;AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA. Presidente: SALGADO MARTINEZ JORGEANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n.QUEDA MODIFICADO EL ARTICULO 11潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES..Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8.Cambio de domicilio social. AVDA DE ARAGON 330 - PARQUE EMPRESARIAL LAS MERCE (MADRID). Datos registrales. T28007 , F 133, S 8, H M 504743, I/A 2 (30.06.11).
30 de Agosto de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 22.07.10. Objeto social: COMPRA, VENTA, ALQUILER, PARCELACION YURBANIZACION DE SOLARES, TERRENOS YFINCAS, COMPRA Y VENTA DE VALORES MOBILIARIOS POR CUENTA PROPIA.Domicilio: C/ VELAZQUEZ 61 1潞 - IZQUIERDA (MADRID). Capital: 3.300,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico:MEDITERRANEAN SEARCH SL. Nombramientos. Adm. Unico: ATALAYA SEVILLANO MARIA TERESA. Datos registrales. T28007 , F 132, S 8, H M 504743, I/A 1 (18.08.10).