Buscador CIF Logo

Actos BORME Gropo Camojan Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gropo Camojan Sl

Actos BORME Gropo Camojan Sl - B93377505

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Malaga para Gropo Camojan Sl con CIF B93377505

馃敊 Perfil de Gropo Camojan Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Malaga

Actos BORME de Gropo Camojan Sl

01 de Febrero de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.497.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 5852, L4759, F 14, S 8, H MA126327, I/A 11 (24.01.23).

20 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: COBO VALLECILLO ANTONIO;COBO GONZALEZ ANTONIO;BLAZQUEZ BUCETA ELISA;BLAZQUEZPRIES ANTONIO;DUARTE MARTINEZ RAFAEL;GIL CASTA脩EDA ISABEL MARIA;PALACIOS TURRILLO IVANAFRANCISCA;ARSUAGA BRIONES IGNACIO;MONELOS MELANIE YASMIN;CACERES LOPEZ MARTIN. Datos registrales. T 5852,L 4759, F 12, S 8, H MA126327, I/A 10 ( 9.07.21).

02 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: H. VERHAEGEN ELS ELISABETH;LOPEZ ALVAREZ ADOLFO. Apoderado: LOPEZ ALVAREZADOLFO;LOPEZ ALVAREZ ADOLFO. Datos registrales. T 5852, L 4759, F 12, S 8, H MA126327, I/A 9 (24.09.19).

04 de Julio de 2019
Cambio de domicilio social. AVDA RICARDO SORIANO 65 - 5潞-3 (MARBELLA). Datos registrales. T 5357, L 4264, F 211, S 8, HMA126327, I/A 7 (25.06.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: COBO GONZALEZ ANTONIO;RAMIREZ PACHECO ROSANA ISABEL. Datos registrales. T 5852, L4759, F 12, S 8, H MA126327, I/A 8 (25.06.19).

13 de Diciembre de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.497.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 5357, L 4264, F211, S 8, H MA126327, I/A 6 ( 3.12.18).

12 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ALVAREZ ADOLFO. Datos registrales. T 5357, L 4264, F 210, S 8, H MA126327, I/A 5(30.12.16).

29 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LODE S. POLLET PETER. Nombramientos. Adm. Solid.: LODE S. POLLET PETER;DE GROOTALEXANDER JAAP. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios.Cambio de domicilio social. C/ CORDOBA 18 - PEPE BRAVO, OFICINA (FUENGIROLA). Datos registrales. T 5357, L 4264, F210, S 8, H MA126327, I/A 4 (20.09.16).

17 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ALVAREZ ADOLFO. Datos registrales. T 5357, L 4264, F 210, S 8, H MA126327, I/A 3 (9.03.16).

17 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: H. VERHAEGEN ELS ELISABETH;LOPEZ ALVAREZ ADOLFO. Datos registrales. T 5357, L 4264, F209, S 8, H MA126327, I/A 2 ( 9.02.15).

21 de Enero de 2015
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 8.01.15. Objeto social: 1. Construcci贸n, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al pormayor y al por menor. Distribuci贸n comercial. Importaci贸n y exportaci贸n. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Mediaci贸n o intermediaci贸n enactividades profesionales. 5. Industrias manufactureras y textiles. 6. Turismo, hosteler铆a y rest. Domicilio: AVDA 1 168 -URBANIZACION LAS CHAPAS, CASA LOS PAV (MARBELLA). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: LODE S.POLLET PETER. Datos registrales. T 5357, L 4264, F 209, S 8, H MA126327, I/A 1 (13.01.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n