Actos BORME de Grossiman Sl
06 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RAMOS NASCIMENTO JOSE MARIO. Nombramientos. Liquidador: RAMOS NASCIMENTO JOSEMARIO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 27209 , F 183, S 8, H M 170977, I/A 17 (26.01.17).
10 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 27209 , F 183, S 8, H M 170977, I/A 16 (28.09.12).
04 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GRILO PASCOAL CARLOS ALBERTO;VIEIRA SIMOES EDMUNDO MEIRIM;RAMOS NASCIMENTOJOSE MARIO. Secretario: VIEIRA SIMOES EDMUNDO MEIRIM. Con.Delegado: RAMOS NASCIMENTO JOSE MARIO. Presidente:GRILO PASCOAL CARLOS ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: RAMOS NASCIMENTO JOSE MARIO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Otros conceptos:MODIFICADOS LOS ARTICULOS 7 Y 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, MODIFICANDO LA DURACION DE LOS CARGOS.Datos registrales. T 27209 , F 182, S 8, H M 170977, I/A 15 (20.04.12).
18 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ BARROS ENRIQUE;SANCHEZ BALLESTA JOSE MANUEL;ZAPATA VIGARA ANA.Presidente: GRILO PASCOAL CARLOS ALBERTO. Secretario: ZAPATA VIGARA ANA. Cons.Del.Man: SANCHEZ BALLESTA JOSEMANUEL;RAMOS NASCIMENTO JOSE MARIO. Revocaciones. Apoderado: MENDOZA DIAZ AGUADO PAZ;GOMEZ BADIOLASUSANA. Apo.Manc.: ZAPATA VIGARA ANA;CAETANO GONZALVES ANTUNES PEDRO MIGUEL. Apoderado: JUAREZ PARRAERNESTO. Nombramientos. Secretario: VIEIRA SIMOES EDMUNDO MEIRIM. Con.Delegado: RAMOS NASCIMENTO JOSEMARIO. Presidente: GRILO PASCOAL CARLOS ALBERTO. Apoderado: MENDOZA DIAZ AGUADO PAZ. Reelecciones. Consejero:GRILO PASCOAL CARLOS ALBERTO;VIEIRA SIMOES EDMUNDO MEIRIM;RAMOS NASCIMENTO JOSE MARIO. Modificacionesestatutarias. ARTICULO 9.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.. Cambio de domicilio social. CTRA DE FUENCARRAL AALCOBENDAS Km 44 - EDIFICIO 4 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 27209 , F 181, S 8, H M 170977, I/A 14 ( 3.01.11).
25 de Enero de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 30,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.103.570,00 Euros. Datos registrales. T 10823 , F 39, S 8, H M170977, I/A 13 (13.01.10).
02 de Marzo de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 10823 , F 39, S 8, H M 170977, I/A 12 (18.02.09).
20 de Enero de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 100.534,94 Euros. Resultante Suscrito: 2.103.540,00 Euros. Datos registrales. T 10823 , F 39, S 8,H M 170977, I/A 11 ( 8.01.09).