Actos BORME de Groupead Europe Sl
06 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: KRAFT HEINZ MICHAEL;KRAFT HEINZ-MICHAEL. Nombramientos. Apo.D.Gral.: SCHMIDTCHRISTIAN. Datos registrales. T 16549 , F 198, S 8, H M 281946, I/A 28 (29.06.20).
25 de Noviembre de 2019Nombramientos. Auditor: RODL & PARTNER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16549 , F 198, S 8, H M 281946, I/A 27(18.11.19).
16 de Enero de 2018Revocaciones. Apoderado: KRAFT HEINZ MICHAEL. Nombramientos. Apoderado: KRAFT HEINZ-MICHAEL. Datos registrales.T 16549 , F 197, S 8, H M 281946, I/A 26 ( 8.01.18).
31 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: HERMANN PIERRE. Presidente: HERMANN PIERRE. Consejero: GONZALEZ SANCHEZ IGNACIO.Secretario: GONZALEZ SANCHEZ IGNACIO. Nombramientos. Consejero: GROBEBORGER RALF;ALONSO PACHECO GONZALOJOSE. Presidente: FESL KARL. Secretario: ALONSO PACHECO GONZALO JOSE. Datos registrales. T 16549 , F 196, S 8, H M281946, I/A 24 (23.08.17).
Revocaciones. Apoderado: ADMINEX SPAIN SL. Nombramientos. Apoderado: ADMINEX SPAIN SL. Datos registrales. T 16549 ,F 197, S 8, H M 281946, I/A 25 (23.08.17).
13 de Septiembre de 2016Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16549 , F 196, S 8, H M 281946, I/A 23 ( 5.09.16).
04 de Septiembre de 2015Cambio de domicilio social. AVDA DE CASTILLA 2 - EDIFICIO FRANCIA, ESCALERA A, (SAN FERNANDO DE HENARES).Datos registrales. T 16549 , F 196, S 8, H M 281946, I/A 22 (26.08.15).
28 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: KRAFT HEINZ MICHAEL. Datos registrales. T 16549 , F 196, S 8, H M 281946, I/A 21 (17.07.14).
23 de Septiembre de 2013Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 16549 , F 196, S 8, H M 281946, I/A 20 (10.09.13).
20 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: COZAR MALDONADO JUAN ALBERTO. Secretario: COZAR MALDONADO JUAN ALBERTO.Nombramientos. Consejero: GONZALEZ SANCHEZ IGNACIO. Secretario: GONZALEZ SANCHEZ IGNACIO. Datos registrales. T16549 , F 195, S 8, H M 281946, I/A 19 ( 7.08.12).
07 de Junio de 2012Cambio de domicilio social. AVDA DE ARAGON, 402 - AUTOVIA A-2, KM. 14, PARQUE (MADRID). Datos registrales. T 16549 , F195, S 8, H M 281946, I/A 18 (28.05.12).
28 de Junio de 2011Revocaciones. Apoderado: WHITTOME MATTHIAS. Nombramientos. Apoderado: KRAFT HEINZ MICHAEL. Datos registrales. T16549 , F 194, S 8, H M 281946, I/A 17 (15.06.11).
14 de Enero de 2011Revocaciones. Apoderado: BARCELO ARISTOY MARIO ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: ADMINEX SPAIN SL. Datosregistrales. T 16549 , F 194, S 8, H M 281946, I/A 16 ( 4.01.11).
30 de Noviembre de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 16549 , F 194, S 8, H M 281946, I/A 15 (18.11.10).
30 de Diciembre de 2009Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 16549 , F 193, S 8, H M 281946, I/A 14 (15.12.09).