Buscador CIF Logo

Actos BORME Gruas Centro Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gruas Centro Sa

Actos BORME Gruas Centro Sa - A78437456

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gruas Centro Sa con CIF A78437456

馃敊 Perfil de Gruas Centro Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gruas Centro Sa

29 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Consejero: SIERRA NAVARRO BENJAMIN;SIERRA NAVARRO ANTONIO;MARIA DOLORES SIERRANAVARRO;SIERRA NAVARRO RAMON;SIERRA NAVARRO MARCELINO;SIERRA NAVARRO MANUEL. Presidente: SIERRANAVARRO BENJAMIN. Secretario: MARIA DOLORES SIERRA NAVARRO. Cons.Del.Man: SIERRA NAVARRO BENJAMIN;MARIADOLORES SIERRA NAVARRO;SIERRA NAVARRO ANTONIO;SIERRA NAVARRO RAMON;SIERRA NAVARROMARCELINO;SIERRA NAVARRO MANUEL. Datos registrales. T 5627 , F 34, S 8, H M 92074, I/A 25 (21.12.20).

03 de Septiembre de 2018
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: SIERRA NAVARRO RAMON;SIERRA NAVARRO ANTONIO.Cons.Del.Man: SIERRA NAVARRO MANUEL;SIERRA NAVARRO BENJAMIN;SIERRA NAVARRO RAMON. Datos registrales. T5627 , F 32, S 8, H M 92074, I/A 21 M (23.08.18).

31 de Agosto de 2018
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: SIERRA NAVARRO MANUEL;SIERRA NAVARRO BENJAMIN;SIERRANAVARRO MARCELINO;SIERRA NAVARRO MARIA DOLORES. Presidente: SIERRA NAVARRO BENJAMIN. Cons.Del.Man:SIERRA NAVARRO MARCELINO. Secretario: SIERRA NAVARRO MARIA DOLORES. Cons.Del.Man: SIERRA NAVARRO MARIADOLORES;SIERRA NAVARRO ANTONIO. Datos registrales. T 5627 , F 32, S 8, H M 92074, I/A 21 M (23.08.18).

17 de Agosto de 2015
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 463/2010. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 3/06/2014. Auto de conclusi贸n delconcurso. Pago a los acreedores. Juzgado: num. 7 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: D. SANTIAGO SENENTMARTINEZ. Resoluciones: MEDIANTE AUTO FIRME DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2014, SE DECLARA LA CONCLUSION DELCONCURSO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 463/2010. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 3/06/2014. Cese de laslimitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 7 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: D. SANTIAGOSENENT MARTINEZ. Resoluciones: COMO CONSECUENCIA DE LA CONCULUSION DEL CONCURSO SE DECLARA EL CESE DELAS LIMITACIONES DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL DEUDOR. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 423/2010. Fecha de resoluci贸n 12/01/2011. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 11JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: MIRIAM IGLESIAS GARCIA-VILLAR. Administrador Concursal. Fecha 3/06/2014,NIF/CIF 02202393M. FERNANDEZ DOYAGUE AMALIA. Datos registrales. T 5627 , F 33, S 8, H M 92074, I/A 24 (10.08.15).

23 de Julio de 2014
Nombramientos. Presidente: SIERRA NAVARRO BENJAMIN. Otros conceptos: Ratificar como CONSEJEROS DELEGADOS a losseis miembros del Consejo, D. Benjam铆n, D& Mar铆a-Dolores, D. Antonio, D. Marcelino, D. Manuel y D. Ram贸n, Sierra Navarro, quienesactuar谩n con car谩cter MANCOMUNADO dos cualesquiera de ellos,ostentaran todas las facultades del Consejo, salvo las indelegables.Datos registrales. T 5627 , F 33, S 8, H M 92074, I/A 23 (15.07.14).

28 de Mayo de 2014
Ceses/Dimisiones. Presidente: SIERRA NAVARRO RUFINO. Consejero: SIERRA NAVARRO RUFINO. Cons.Del.Man: SIERRANAVARRO RUFINO. Datos registrales. T 5627 , F 33, S 8, H M 92074, I/A 22 (21.05.14).

14 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Presidente: SIERRA NAVARRO RUFINO. Secretario: SIERRA NAVARRO MARIA DOLORES. Consejero: SIERRANAVARRO MANUEL;SIERRA NAVARRO BENJAMIN;SIERRA NAVARRO ANTONIO;SIERRA NAVARRO RUFINO;SIERRANAVARRO MARCELINO;SIERRA NAVARRO RAMON;SIERRA NAVARRO MARIA DOLORES. Cons.Del.Man: SIERRA NAVARROMANUEL;SIERRA NAVARRO BENJAMIN;SIERRA NAVARRO ANTONIO;SIERRA NAVARRO RUFINO;SIERRA NAVARROMARCELINO;SIERRA NAVARRO RAMON;SIERRA NAVARRO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 5627 , F 32, S 8, H M92074, I/A 21 (27.10.11).

04 de Noviembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: COLLADO GUISADO RAMON. Datos registrales. T 5627 , F 32, S 8, H M 92074, I/A 20 (24.10.11).

23 de Febrero de 2011
Otros conceptos: CONVERSION DEL MANDAMIENTO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2011, CONCURSO ABREVIADO 423/2010,DE ANOTACION PREVENTIVA A INSCRIPCION, SEGUN AUTO QUE HA QUEDADO FIRME EL 25 DE ENERO DE 2011. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 423/2010. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 25/01/2011. Auto de declaraci贸n de concurso.Voluntario. Juzgado: num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: MIRIAM IGLESIAS GARCIA-VILLAR. Datosregistrales. T 5627 , F 32, S 8, H M 92074, I/A 19 (14.02.11).

03 de Febrero de 2011
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 423/2010. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 12/01/2011. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: MIRIAM IGLESIAS GARCIA-VILLAR.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 423/2010. Fecha de resoluci贸n 12/01/2011. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: MIRIAM IGLESIAS GARCIA-VILLAR. Administrador Concursal.Fecha 12/01/2011, NIF/CIF 2202393M. FERNANDEZ DOYAGUE AMALIA. Datos registrales. T 5627 , F 32, S 8, H M 92074, I/A A(24.01.11).

03 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Auditor: BERMUDEZ Y TRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Datos registrales. T 5627 , F 31,S 8, H M 92074, I/A 18 (12.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n