Actos BORME de Gruas Lozano Jerez Sl
02 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. LiqManc: LOZANO JIMENEZ FRANCISCO DOMINGO;LOZANO JIMENEZ JUAN. Adm. Mancom.: LOZANOJIMENEZ FRANCISCO DOMINGO;LOZANO JIMENEZ JUAN. Nombramientos. LiqManc: LOZANO JIMENEZ FRANCISCODOMINGO;LOZANO JIMENEZ JUAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aLiquidadores Mancomunados. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 3390 , F 196, S 8, H SE 46916, I/A 14(25.07.19).
05 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: MANUEL REYES COTAN. Otros conceptos: REVOCADOS TODOS los poderes conferidos por lasociedad a favor de DON MANUEL REYES COTAN, no constando inscritos los conferidos en las siguientes fechas: 15 de noviembrede 2011, 12 de abril de 2012, protocolo 28, y 7 de enero de 2014, protocolo 14.- Datos registrales. T 3390 , F 194, S 8, H SE 46916,I/A 11 (25.08.17).
Nombramientos. Apoderado: SOLA TEYSSIERE JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3390 , F 194, S 8, H SE 46916, I/A 12(25.08.17).
Nombramientos. Apoderado: AROCA JAEN JUAN LUIS. Datos registrales. T 3390 , F 195, S 8, H SE 46916, I/A 13 (28.08.17).
28 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: LOZANO JIMENEZ JOSE MARIA;JIMENEZ GARDE RITA. Secretario: LOZANO JIMENEZ JOSEMARIA. Cons.Del.Sol: LOZANO JIMENEZ JOSE MARIA. Consejero: LOZANO JIMENEZ JUAN. Presidente: LOZANO JIMENEZ JUAN.Consejero: LOZANO JIMENEZ FRANCISCO DOMINGO. Vicepresid.: LOZANO JIMENEZ FRANCISCO DOMINGO. Consejero:JIMENEZ LOPEZ FELIPE. Cons.Del.Sol: LOZANO JIMENEZ FRANCISCO DOMINGO;LOZANO JIMENEZ JUAN. Nombramientos.Adm. Mancom.: LOZANO JIMENEZ FRANCISCO DOMINGO;LOZANO JIMENEZ JUAN. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 3390 , F 193, S 8, H SE 46916,I/A 10 (14.06.17).
20 de Diciembre de 2013Modificaciones estatutarias. 2. Creaci贸n p谩gina web corporativa... Funcionamiento Junta Gral.-. P谩gina web de la sociedad.Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.gruaslozano.com. Datos registrales. T 3390 , F 193, S 8, H SE 46916, I/A 9 (11.12.13).
22 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 304.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 3390 , F 192, S 8, H SE 46916, I/A 8 ( 8.02.11).
25 de Junio de 2010Nombramientos. Auditor: RUBIO MEMBRIVE Y GISBERT SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 3390 , F 192, S 8,H SE 46916, I/A 7 ( 9.06.10).