Actos BORME de Gruas Y Logistica Del Sur Sl
28 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SANZ IBARRA MARIA-ELENA. Datos registrales. T 17050 , F 17, S 8, H M 291752, I/A 25 (20.12.23).
03 de Agosto de 2023Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ BILBAO ANA;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANA BELEN;MARTIN FRANCO JORGE.Nombramientos. Apo.Man.Soli: VITAL URGOITI CARLOS;PEREZ LOPEZ ELENA MARIA;CUTANDA ESCRIBANO MARIA. Datosregistrales. T 17050 , F 16, S 8, H M 291752, I/A 24 (27.07.23).
01 de Marzo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GAMEZ MARTINEZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 17050 , F 16, S 8, H M 291752, I/A 23(22.02.23).
14 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: ROCARIES THIERRY. Nombramientos. Representan: GARCIA NAVARRO PEDRO. Datosregistrales. T 17050 , F 16, S 8, H M 291752, I/A 22 ( 4.12.21).
04 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DESALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES. Apo.Man.Soli: DIAZ LARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZMARTA ISABEL. Apoderado: FERNANDEZ BILBAO ANA. Datos registrales. T 17050 , F 16, S 8, H M 291752, I/A 21 (27.09.21).
22 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apoderado: MORENO GOTOR RAMON. Datos registrales. T 17050 , F 14, S 8, H M 291752, I/A 20 (15.09.21).
22 de Julio de 2021Cambio de domicilio social. AVDA DE BRUSELAS 20, (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 17050 , F 14, S 8, H M 291752, I/A19 (15.07.21).
28 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: GRAVALOS GARCIA JAVIER ANGEL. Datos registrales. T 17050 , F 14, S 8, H M 291752, I/A 18(21.04.21).
29 de Octubre de 2020Modificaciones estatutarias. INCLUIR EL ARTICULO 4 BIS DE LOS ESTATUTOS. Datos registrales. T 17050 , F 13, S 8, H M291752, I/A 17 (22.10.20).
18 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;GONZALEZ TOJO ANDRES;DIAZLARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL;FERNANDEZ BILBAO ANA;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANABELEN;MARTIN FRANCO JORGE. Datos registrales. T 17050 , F 13, S 8, H M 291752, I/A 16 (11.02.20).
15 de Febrero de 2019Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL.Datos registrales. T 17050 , F 8, S 8, H M 291752, I/A 15 ( 8.02.19).
09 de Octubre de 2018Ampliacion del objeto social. A la prestación de servicios relativos a la limpieza industrial de toda clase de edificios , oficinas yestablecimientos comerciales o industriales. A la realización de cualquier actividad análoga y complementaria a las anteriormentemencionadas. Datos registrales. T 17050 , F 8, S 8, H M 291752, I/A 14 ( 1.10.18).
05 de Octubre de 2017Revocaciones. Apoderado: ZABALA FERNANDEZ GORKA. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BILBAO ANA. Datosregistrales. T 17050 , F 8, S 8, H M 291752, I/A 13 (27.09.17).
12 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: DOPICO RUIZ MARIA ARANZAZU. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIAZ LARRIETAKOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL. Datos registrales. T 17050 , F 7, S 8, H M 291752, I/A 12 ( 1.04.16).
17 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Representan: VALDES GUINEA CRISTOBAL. Nombramientos. Representan: ROCARIES THIERRY. Datosregistrales. T 17050 , F 7, S 8, H M 291752, I/A 11 ( 6.11.15).
08 de Abril de 2015Revocaciones. Apoderado: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;IGLESIASSANZ ALBERTO;MUÑOZ CUEVAS FERNANDO;RIVERA LATAS ISABEL;GARCIA TEMPRANO MAHEY;MARTIN CORPACRISTINA;CEPEDA BAZA VANESSA;PEREZ DEL NOTARIO PUENTE ELENA;CERON ECHEVARRIA SOLEDAD;ORDOÑEZ PEREZMARIA-JOSE. Datos registrales. T 17050 , F 7, S 8, H M 291752, I/A 10 (30.03.15).
12 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PUIG DE RATO LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: BERGE MARITIMA SL. Representan:VALDES GUINEA CRISTOBAL. Datos registrales. T 17050 , F 7, S 8, H M 291752, I/A 9 ( 3.11.14).
13 de Agosto de 2013Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 65 (MADRID).Datos registrales. T 17050 , F 6, S 8, H M 291752, I/A 8 ( 6.08.13).
31 de Julio de 2013Declaración de unipersonalidad. Socio único: NOR SHIPPING SL. Datos registrales. T 17050 , F 6, S 8, H M 291752, I/A 7(23.07.13).
12 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DESALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES;DOPICO RUIZ MARIA ARANZAZU;ZABALA FERNANDEZ GORKA. Datosregistrales. T 17050 , F 5, S 8, H M 291752, I/A 6 ( 2.08.11).
06 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: GRAVALOS GARCIA JAVIER ANGEL. Datos registrales. T 17050 , F 4, S 8, H M 291752, I/A 5(25.05.11).
16 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apoderado: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;IGLESIASSANZ ALBERTO;MUÑOZ CUEVAS FERNANDO;RIVERA LATAS ISABEL;GARCIA TEMPRANO MAHEY;MARTIN CORPACRISTINA;CEPEDA BAZA VANESSA;PEREZ DEL NOTARIO PUENTE ELENA;CERON ECHEVARRIA SOLEDAD;ORDOÑEZ PEREZMARIA-JOSE. Datos registrales. T 17050 , F 3, S 8, H M 291752, I/A 4 ( 2.12.10).