Actos BORME de Grulan Sl
31 de Agosto de 2023Revocaciones. Apoderado: ARGILA GARCIA PILAR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRIADO SANZ RAFAEL;COLMENAREJOALONSO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 45393 , F 220, S 8, H M 265286, I/A 56 (24.08.23).
25 de Julio de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.332,20 Euros. Resultante Suscrito: 10.117.414,30 Euros. Datos registrales. T 34400 , F224, S 8, H M 265286, I/A 55 (18.07.23).
08 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: VAS PIRIS TAMARA;FIGUEROA NAVARRO PILAR. Nombramientos. Apoderado: ANGEL OGANDOJAVIER;FIGUEROA NAVARRO PILAR;VERDES MONTENEGRO ROLLAN PALOMA;CARPIO GARCIA LAURA;NOVILLO BAYANOCRISTINA. Datos registrales. T 34400 , F 223, S 8, H M 265286, I/A 54 ( 1.03.23).
23 de Febrero de 2023Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 34400 , F 222, S8, H M 265286, I/A 53 (16.02.23).
04 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: GINES GOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 34400 , F 222, S 8, H M 265286, I/A 52 (28.12.22).
03 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: CALVO ANGUIS MARIA GLORIA;GARCIA BELDA MARIA AUXILIADORA;MONTESINOSBALLESTEROS LUIS;LASSALETTA GONZALEZ JUAN MARIA;CRESPO MOTILLA SOLEDAD;VAS PIRIS TAMARA;GARCIAGARCIA MARIA DEL PILAR;ARGILA GARCIA PILAR;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINESGOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 34400 , F 220, S 8, H M 265286, I/A 51 (26.10.22).
31 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: DE LA TORRE MU脩OZ MARIA NIEVES. Datos registrales. T 34400 , F 220, S 8, H M 265286, I/A 50(24.10.22).
24 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: VEGA DE CELIS ANA;CALVO ANGUIS MARIA GLORIA;GARCIA BELDA MARIAAUXILIADORA;MONTESINOS BALLESTEROS LUIS;LASSALETTA GONZALEZ JUAN MARIA;RANZ HERRANZ RAUL;VAS PIRISTAMARA;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO;CRESPO MOTILLASOLEDAD;ARGILA GARCIA PILAR. Datos registrales. T 34400 , F 89, S 8, H M 265286, I/A 49 (17.10.22).
09 de Septiembre de 2022Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 29 la reducci贸n de capital, siendo lo correcto una reducci贸n de 312.459,90 eurosresultando un capital total de 10.124.746,50 euros. Datos registrales. T 34400 , F 78, S 8, H M 265286, I/A 29 ( 9.04.18).
12 de Julio de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ-PE脩A MORALES MARTA. Apoderado: SANCHEZ RUIZ ANGELA. Nombramientos.Apoderado: ARGILA GARCIA PILAR. Datos registrales. T 34400 , F 88, S 8, H M 265286, I/A 48 ( 5.07.22).
31 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 34400 , F 88, S 8, H M265286, I/A 47 (24.01.22).
03 de Enero de 2022Revocaciones. Apoderado: ANGEL OGANDO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: CRESPO MOTILLA SOLEDAD. Datosregistrales. T 34400 , F 87, S 8, H M 265286, I/A 46 (27.12.21).
10 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apoderado: VEGA DE CELIS ANA. Datos registrales. T 34400 , F 84, S 8, H M 265286, I/A 42 ( 3.09.21).
Nombramientos. Apoderado: OSMA HERNANDEZ JORGE. Datos registrales. T 34400 , F 85, S 8, H M 265286, I/A 43 ( 3.09.21).
Nombramientos. Apoderado: CALVO ANGUIS MARIA GLORIA;GARCIA BELDA MARIA AUXILIADORA;MONTESINOSBALLESTEROS LUIS;LASSALETTA GONZALEZ JUAN MARIA;RANZ HERRANZ RAUL;VAS PIRIS TAMARA;ANGEL OGANDOJAVIER;SANCHEZ RUIZ ANGELA;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO.Datos registrales. T 34400 , F 85, S 8, H M 265286, I/A 44 ( 3.09.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA BELDA MARIA;RANZ HERRANZ RAUL. Apo.Manc.: RANZ HERRANZ RAUL;SANCHEZ RUIZANGELA. Apo.Sol.: SANCHEZ RUIZ ANGELA;VAS PIRIS TAMARA. Apo.Manc.: VAS PIRIS TAMARA;GARCIA DE LA FUENTE ROSAMARIA. Apo.Sol.: GARCIA DE LA FUENTE ROSA MARIA;FIGUEROA NAVARRO PILAR. Apo.Manc.: FIGUEROA NAVARROPILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU. Apo.Sol.: BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Apo.Manc.:GINES GOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 34400 , F 87, S 8, H M 265286, I/A 45 ( 3.09.21).
15 de Julio de 2021Nombramientos. Con.Delegado: LANTERO MORENO ANDRES;LANTERO MIRANDA PELAYO;LANTERO CERVERAPEDRO;LANTERO LIZCANO JORGE. Datos registrales. T 34400 , F 84, S 8, H M 265286, I/A 41 ( 8.07.21).
02 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 34400 , F 84, S 8, H M265286, I/A 40 (23.02.21).
01 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: LANTERO MORENO ANDRES;LANTERO MIRANDA PELAYO;LANTERO CERVERAPEDRO;LANTERO LIZCANO JORGE. Reelecciones. Consejero: LANTERO MORENO ANDRES;LANTERO MIRANDAPELAYO;LANTERO LIZCANO JORGE;LANTERO CERVERA PEDRO;CORRALES LANTERO MARIA PILAR. Presidente: LANTEROMORENO ANDRES. Secretario: LANTERO MIRANDA PELAYO. Consejero: LORECOR INVESMENT SL. VsecrNoConsj:FERNANDEZ-LOECHES MARTINEZ CARLOS. Datos registrales. T 34400 , F 83, S 8, H M 265286, I/A 39 (22.02.21).
21 de Enero de 2021Modificaciones estatutarias. 6. Nueva redacci贸n del art铆culo 6 de los estatutos. . Datos registrales. T 34400 , F 82, S 8, H M265286, I/A 38 (14.01.21).
07 de Octubre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: BENEITEZ PANIZO BEATRIZ;SANCHEZ RUIZ ANGELA;VAS PIRIS TAMARA;ROSA MARIA GARCIADE LA FUENTE;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Datos registrales.T 34400 , F 81, S 8, H M 265286, I/A 36 (30.09.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA BELDA MARIA;RANZ HERRANZ RAUL. Apo.Manc.: RANZ HERRANZ RAUL;SANCHEZ RUIZANGELA. Apo.Sol.: SANCHEZ RUIZ ANGELA;VAS PIRIS TAMARA. Apo.Manc.: VAS PIRIS TAMARA;GARCIA DE LA FUENTE ROSAMARIA. Apo.Sol.: GARCIA DE LA FUENTE ROSA MARIA;FIGUEROA NAVARRO PILAR. Apo.Manc.: FIGUEROA NAVARROPILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU. Apo.Sol.: BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Apo.Manc.:GINES GOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 34400 , F 81, S 8, H M 265286, I/A 37 (30.09.20).
14 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: BURRULL FERNANDEZ MARIO. Datos registrales. T 34400 , F 81, S 8, H M 265286, I/A 35 ( 7.09.20).
11 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ-PE脩A MORALES MARTA. Datos registrales. T 34400 , F 80, S 8, H M 265286, I/A 34 (4.02.20).
22 de Enero de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: BENEITEZ PANIZO BEATRIZ;SANCHEZ RUIZ ANGELA;VAS PIRIS TAMARA;ROSA MARIAGARCIA DE LA FUENTE;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Datosregistrales. T 34400 , F 79, S 8, H M 265286, I/A 33 (15.01.20).
22 de Abril de 2019Nombramientos. Representan: CORT LANTERO JUAN. Consejero: LORECOR INVESMENT SL. Modificaciones estatutarias.Modificaci贸n del Art铆culo 23潞 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 34400 , F 79, S 8, H M 265286, I/A 32 (11.04.19).
26 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CORT LANTERO JUAN. Datos registrales. T 34400 , F 78, S 8, H M 265286, I/A 31 (19.03.19).
13 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: HOLZBACHER VALERO ENRIC;LANTERO MORENO ANDRES. Datos registrales. T 34400 , F 78, S 8,H M 265286, I/A 30 ( 4.12.18).
17 de Abril de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 10.124.746,50 Euros. Resultante Suscrito: 312.459,90 Euros. Datos registrales. T 34400 ,
13 de Abril de 2018Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 34400 , F 78, S 8, H M265286, I/A 28 ( 6.04.18).
17 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: LANTERO LIZCANO CARMEN;LANTERO MORENO PABLO. Nombramientos. VsecrNoConsj:FERNANDEZ-LOECHES MARTINEZ CARLOS. Consejero: LANTERO MORENO ANDRES;LANTERO MIRANDA PELAYO;LANTEROLIZCANO JORGE;CORT LANTERO JUAN;LANTERO CERVERA PEDRO;CORRALES LANTERO MARIA PILAR. Presidente:LANTERO MORENO ANDRES. Secretario: LANTERO MIRANDA PELAYO. Co.De.Ma.So: LANTERO MORENO ANDRES;LANTEROMIRANDA PELAYO;LANTERO CERVERA PEDRO;LANTERO LIZCANO JORGE. Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.637.263,70Euros. Resultante Suscrito: 10.437.206,40 Euros. Modificaciones estatutarias. 23. Remuneraci贸n de los Administradores oConsejeros de la Sociedad.-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejode administraci贸n. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CARMOLAN SL. CARMOVEZ SL. ENCIN SL. Datos registrales.T 34400 , F 72, S 8, H M 265286, I/A 27 (10.01.18).
11 de Marzo de 2016Reelecciones. Adm. Mancom.: LANTERO LIZCANO CARMEN;LANTERO MORENO PABLO. Modificaciones estatutarias.Modificaci贸n de los art铆culos 6, 7, 8 y 20 de los estatutos sociales. Cambio de objeto social. (i) La inversi贸n en todo tipo de valoresmobiliarios, incluyendo la compra, venta, suscripci贸n, desembolso, tenencia y gravamen de acciones y participaciones sociales, as铆como de obligaciones, canjeables o no, bonos comerciales, partes de fundador, bonos de disfrute, valores mobiliarios de renta f.Datos registrales. T 18260 , F 119, S 8, H M 265286, I/A 25 ( 4.03.16).
Revocaciones. Apoderado: TRIGUERO IZQUIERDO MANUEL;MENA TRABA MANUEL;NAVARRO SANCHEZ MANUEL;CALVOANGUIS GLORIA;NAVARRO SANCHEZ ANTONIO;CANTERO ALONSO DAVID. Datos registrales. T 34400 , F 72, S 8, H M265286, I/A 26 ( 4.03.16).
02 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: HOLZBACHER VALERO ENRIC;LANTERO MORENO ANDRES;CALVO ANGUIS GLORIA;VILAGARRIDO DAVID;COFRADES ACEBES OLGA. Datos registrales. T 18260 , F 116, S 8, H M 265286, I/A 24 (24.11.14).
31 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Representan: CORT LANTERO JUAN;LANTERO MIRANDA PELAYO. Consejero: MALLO CARCIOFFIJORGE;LANTERO MORENO ANDRES;LANTERO ROZPIDE JAVIER;LANTERO LIZCANO JORGE;HORCAJO AGUIRREALBERTO;HERNANDEZ IBA脩EZ LUIS;LORECOR INVESMENT SL. Presidente: MALLO CARCIOFFI JORGE. Vicepresid.: LANTEROMORENO ANDRES. Secretario: LANTERO ROZPIDE JAVIER. Consejero: BLACK SHAWN ENERGY SL. Co.De.Ma.So: MALLOCARCIOFFI JORGE;LANTERO MORENO ANDRES. Consejero: VILLAZAN GIL BERNARDO. Nombramientos. Adm. Mancom.:LANTERO LIZCANO CARMEN;LANTERO MORENO PABLO. Modificaciones estatutarias. SE APRUEBA UN NUEVO TEXTO DEESTATUTOS SOCIALES. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados.Ampliacion del objeto social. ADQUISICION, TENENCIA, ADMINISTRACION, EXPLOTACION Y VENTA DE BIENES MUEBLESDESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE FABRICACION, MANIPULACION Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE MERCADERIASY MATERIALES FABRICADOS A PARTIR DEL PAPEL, PLASTICO O SUS DERIVADOS, CARTON ONDULADO CARTONCOMPACTO. Datos registrales. T 18260 , F 111, S 8, H M 265286, I/A 23 (21.03.14).
06 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN. Nombramientos. Consejero: VILLAZAN GILBERNARDO. Datos registrales. T 18260 , F 110, S 8, H M 265286, I/A 22 (23.08.11).
30 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MALLO CARCIOFFI JORGE;LANTERO MORENO ANDRES;LANTERO ROZPIDE JAVIER.Nombramientos. Co.De.Ma.So: MALLO CARCIOFFI JORGE;LANTERO MORENO ANDRES. Datos registrales. T 18260 , F 110, S8, H M 265286, I/A 21 (16.12.10).
07 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: LANTERO MIRANDA PELAYO. Nombramientos. Representan: LANTERO MIRANDA PELAYO.Consejero: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN;BLACK SHAWN ENERGY SL. Datos registrales. T 18260 , F 109, S 8,H M 265286, I/A 20 (23.11.10).
07 de Junio de 2010Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ BLASCO LUIS;NAVARRO SANCHEZ ANTONIO;TRIGUERO IZQUIERDOMANUEL;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU. Nombramientos. Apoderado: CALVO ANGUIS GLORIA;NAVARRO SANCHEZANTONIO;CANTERO ALONSO DAVID. Datos registrales. T 18260 , F 108, S 8, H M 265286, I/A 19 (25.05.10).
28 de Mayo de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 71.639,20 Euros. Resultante Suscrito: 3.799.942,70 Euros. Datos registrales. T 18260 , F107, S 8, H M 265286, I/A 18 (19.05.10).
10 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MALLO CARCIOFFI JORGE. Presidente: MALLO CARCIOFFI JORGE. Consejero: LANTEROROZPIDE JAVIER. Secretario: LANTERO ROZPIDE JAVIER. Consejero: LANTERO ROZPIDE JORGE. Vicepresid.: LANTERO
28 de Mayo de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 66.711,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.871.581,90 Euros. Datos registrales. T 18260 , F