Actos BORME de Grupiteaf Sl
02 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.D.Gral.: GIRONA LOPEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 1662, L 1223, F 81, S 8, H CS 37049, I/A 2(23.02.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: MOLINA MOLLA ALEJANDRO;MOROS PLANELLES JUAN VICENTE;TORRENT CORTS JOSEVICENTE;SEGARRA TIRADO JOSE VICENTE;COLOMER TORRES MARIA FRANCISCA. Datos registrales. T 1662, L 1223, F 81,S 8, H CS 37049, I/A 3 (23.02.15).
25 de Noviembre de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 10.11.14. Objeto social: Inspecci贸n t茅cnica de equipos de aplicaciones fitosanitarias, yformaci贸n en el uso de dichos equipos.Aplicaci贸n y gesti贸n de tratamientos con biocidas y asesoramiento en gesti贸n integrada deplagas.Otro servicio o funci贸n empresarial que sea propio, del objeto anterior. Domicilio: POLIG SUPOI-8, C/ DELS IBERS 24(ALMAZORA). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: INTERCOOP COMERCIAL AGROPECUARIA COOP V.Presidente: COARVAL COOP.V. Consejero: FEDERACIO COOPERATIVES AGROALIMENTARIES DE LA COMU;COARVALCOOP.V. Secretario: INTERCOOP COMERCIAL AGROPECUARIA COOP V. Otros conceptos: Dispensa de Prohibici贸n deCompetencia. Datos registrales. T 1662, L 1223, F 79, S 8, H CS 37049, I/A 1 (18.11.14).