Buscador CIF Logo

Actos BORME Grupo Alvic Fr Mobiliario Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Grupo Alvic Fr Mobiliario Sl

Actos BORME Grupo Alvic Fr Mobiliario Sl - B64542152

Tenemos registrados 34 Actos BORME del Registro Mercantil de Jaen para Grupo Alvic Fr Mobiliario Sl con CIF B64542152

馃敊 Perfil de Grupo Alvic Fr Mobiliario Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Jaen

Actos BORME de Grupo Alvic Fr Mobiliario Sl

14 de Junio de 2023
Nombramientos. Consejero: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN. Datos registrales. T 645 , F 108, S 8, H J 24347,I/A 10 ( 8.06.23).

Nombramientos. Consejero: VALDES GUINEA CRISTOBAL. Cons.Del.Sol: VALDES GUINEA CRISTOBAL. Datos registrales. T645 , F 108, S 8, H J 24347, I/A 11 ( 8.06.23).

18 de Enero de 2023
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 645 , F 108, S 8, H J 24347, I/A 9 (12.01.23).

04 de Noviembre de 2022
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SANZ DIEZ DE ULZURRUN CARLOS LOZANO. Nombramientos. VsecrNoConsj: BLANCOSAN PASTOR JUAN. Datos registrales. T 645 , F 107, S 8, H J 24347, I/A 8 (27.10.22).

17 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: PADILLA LOPEZ ANTONIO;VIANA SANCHEZ FERMIN;ROSALES PEREZ JAVIER. Nombramientos.Apo.Man.Soli: PADILLA LOPEZ ANTONIO;VIANA SANCHEZ FERMIN;ROSALES PEREZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T645 , F 105, S 8, H J 24347, I/A 5 ( 9.11.20).

08 de Julio de 2020
Cambio de domicilio social. C/ ALCALDE JUAN VALLEJO 27 (ALCAUDETE). Datos registrales. T 645 , F 104, S 8, H J 24347, I/A2 ( 2.07.20).

Nombramientos. VsecrNoConsj: SANZ DIEZ DE ULZURRUN CARLOS LOZANO. Datos registrales. T 645 , F 104, S 8, H J 24347,I/A 3 ( 2.07.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: PADILLA LOPEZ ANTONIO;VIANA SANCHEZ FERMIN;ROSALES PEREZ FRANCISCOJAVIER;MONTMANY CORNELLAS CONCEPCION. Datos registrales. T 645 , F 105, S 8, H J 24347, I/A 4 ( 2.07.20).

20 de Marzo de 2020
Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 14 la reelecci贸n de AUDITPLUS MANAGEMENT SLP como auditor de cuentassiendo lo correcto auditor de cuentas consolidadas. Datos registrales. T 32415 , F 98, S 8, H M 583465, I/A 14 ( 6.03.19).

Ceses/Dimisiones. Auditor: AUDITPLUS MANAGEMENT SLP. Aud.C.Con.: AUDITPLUS MANAGEMENT SLP. Nombramientos.Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39774 , F 158, S 8, H M 583465, I/A 21 (13.03.20).

07 de Febrero de 2020
Otros conceptos: Concedida una SUBVENCION A FONDO PERDIDO por un importe de 1.945.978,86 EUROS para la zona depromoci贸n econ贸mica de ANDALUCIA, por resoluci贸n de fecha 18 de noviembre de 2019. Datos registrales. T 39774 , F 152, S 8, HM 583465, I/A 16/M (31.01.20).

05 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: MONTMANY CORNELLAS CONCEPCION. Datos registrales. T 39774 , F 155, S 8, H M 583465, I/A19 (29.01.20).

Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ PORRAS ROCIO;PADILLA LOPEZ ANTONIO;VIANA SANCHEZ FERMIN;PADILLALOPEZ ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: PADILLA LOPEZ ANTONIO;VIANA SANCHEZ FERMIN;ROSALES PEREZJAVIER. Datos registrales. T 39774 , F 156, S 8, H M 583465, I/A 20 (29.01.20).

04 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROSALES EXPOSITO ALEJANDRO;ROSALES PEREZ ALEJANDRO. Secretario: ROSALES PEREZALEJANDRO. Cons.Del.Sol: ROSALES PEREZ ALEJANDRO. Consejero: ROSALES PEREZ CARLOS. Cons.Del.Sol: ROSALESPEREZ CARLOS. Vicepresid.: ROSALES PEREZ CARLOS. VsecrNoConsj: GARCIA MOCHALES CORREA JUAN. Nombramientos.Consejero: COBO BACHILLER IGNACIO;OCHOA PANISELLO JUAN-IGNACIO;SERNA GARCIA-CONDE CRISTINA;ARTA CAPITALSGEIC SA;ARTA CAPITAL FUND II B SCR SA;ARTA CAPITAL FUND II A SCR SA. SecreNoConsj: LOPEZ JORRIN HERNANDEZALVARO. Representan: JIMENEZ-UGARTE LUELMO NICOLAS;ESCARIO DEL CORRO JACOBO;ALBA RIPOLLES JAIME.Modificaciones estatutarias. 1. Refundici贸n de estatutos.-. Datos registrales. T 39774 , F 151, S 8, H M 583465, I/A 16 (28.01.20).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ARIZONA BIDCO SL. Datos registrales. T 39774 , F 155, S 8, H M 583465, I/A 17(28.01.20).

Nombramientos. Consejero: LLUCH PAUNER JORGE. Datos registrales. T 39774 , F 155, S 8, H M 583465, I/A 18 (28.01.20).

13 de Marzo de 2019
Reelecciones. Auditor: AUDITPLUS MANAGEMENT SLP. Datos registrales. T 32415 , F 98, S 8, H M 583465, I/A 14 ( 6.03.19).

17 de Septiembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: PEREZ GIANINNI SANTOS JORGE. Datos registrales. T 32415 , F 98, S 8, H M 583465, I/A 13(10.09.18).

12 de Marzo de 2018
Reelecciones. Auditor: AUDITPLUS MANAGEMENT SLP. Datos registrales. T 32415 , F 98, S 8, H M 583465, I/A 12 ( 5.03.18).

13 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GIANINNI SANTOS JORGE. Datos registrales. T 32415 , F 97, S 8, H M 583465, I/A 11 (5.02.18).

25 de Octubre de 2016
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MKIT MODULARES LAS PALMAS SL. TRANSFORMADOS DE LA MADERA FAROSOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 32415 , F 93, S 8, H M 583465, I/A 10 (17.10.16).

20 de Enero de 2016
Modificaciones estatutarias. 26. De la remuneracion de los Administradores.-. Datos registrales. T 32415 , F 92, S 8, H M 583465,I/A 8 (12.01.16).

Ceses/Dimisiones. Presidente: ROSALES EXPOSITO ALEJANDRO. Revocaciones. Apoderado: ROSALES EXPOSITOALEJANDRO. Nombramientos. VsecrNoConsj: GARCIA MOCHALES CORREA JUAN. Presidente: ROSALES PEREZ FRANCISCOJAVIER. Vicepresid.: ROSALES PEREZ CARLOS. Datos registrales. T 32415 , F 92, S 8, H M 583465, I/A 9 (12.01.16).

15 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Aud.C.Con.: AUDITPLUS MANAGEMENT SLP. Datos registrales. T 32415 , F 92, S 8, H M 583465, I/A 7 ( 7.12.15).

15 de Enero de 2015
Nombramientos. Auditor: AUDITPLUS MANAGEMENT SLP. Datos registrales. T 32415 , F 91, S 8, H M 583465, I/A 6 ( 8.01.15).

01 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: VIANA SANCHEZ FERMIN. Datos registrales. T 32415 , F 90, S 8, H M 583465, I/A 4 (24.11.14).

Nombramientos. Apoderado: PADILLA LOPEZ ANTONIO. Datos registrales. T 32415 , F 90, S 8, H M 583465, I/A 5 (24.11.14).

04 de Noviembre de 2014
Otros conceptos: LA PRESENTE SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD "CORPORACION DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES ALCAJAR SL " , CAMBIADA SU DENOMINACION POR LA DE " GRUPOALVIC FR MOBILIARIO SL ".- Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 32410 , F 189, S 8, H M 583371, I/A 3(24.10.14).

27 de Octubre de 2014
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR LA INSCRIPCION 2& DE TRASLADO DE DOMICILIO CON LA DENOMINACION"GRUPO ALVIC FR INMOBILIARIO SL" SIENDO LO CORRECTO "GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO SL". Datos registrales. T 32410, F 189, S 8, H M 583371, I/A 2 (24.07.14).

01 de Agosto de 2014
Cambio de domicilio social. C/ GAVILAN 2 - P.I. LOS GALLEGOS (FUENLABRADA). Datos registrales. T 32410 , F 189, S 8, H M583371, I/A 2 (24.07.14).

12 de Diciembre de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDITPLUS MANAGEMENT SLP. Datos registrales. T 37045 , F 153, S 8, H B 168211, I/A 30(28.11.11).

10 de Mayo de 2010
Revocaciones. APODERADO: RODRIGUEZ PORRAS ROCIO. Datos registrales. T 37045 , F 153, S 8, H B 168211, I/A 28(27.04.10).

Nombramientos. APODERADO: VIANA SANCHEZ FERMIN. Datos registrales. T 37045 , F 153, S 8, H B 168211, I/A 29(27.04.10).

17 de Febrero de 2009
Revocaciones. AUDIT.CUENT.: ERNST AND YOUNG SL. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDITPLUS MANAGEMENT SLP.Datos registrales. T 37045 , F 153, S 8, H B 168211, I/A 27 ( 4.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n