Actos BORME de Grupo Antolin Valplas Sa
22 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: PRADO MEDIAVILLA MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: PRADO MEDIAVILLA MIGUEL ANGEL.Nombramientos. Consejero: SANZ GIMENEZ RICO FERNANDO. Vicepresid.: SANZ GIMENEZ RICO FERNANDO. Datosregistrales. T 775, L 566, F 3, S 8, H BU 15254, I/A 19 (16.12.22).
11 de Agosto de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.701.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 99.000,00 Euros. Datos registrales. T 775, L566, F 2, S 8, H BU 15254, I/A 18 ( 5.08.22).
15 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCUAL SANTOS JESUS. Con.Delegado: PASCUAL SANTOS JESUS. Presidente: PASCUALSANTOS JESUS. Nombramientos. Consejero: SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON. Datos registrales. T 775, L 566, F 2, S 8, H BU15254, I/A 16 ( 9.06.22).
Nombramientos. Presidente: SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON. Con.Delegado: SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON. Datosregistrales. T 775, L 566, F 2, S 8, H BU 15254, I/A 17 ( 9.06.22).
05 de Enero de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: ARIZNAVARRETA ESTEBAN ANSELMO JAVIER;NAVARRO NAVE EDUARDO. Nombramientos.Apo.Manc.: BULTO CHIRIVELLA SANTIAGO;NAVARRO NAVE EDUARDO. Datos registrales. T 775, L 566, F 1, S 8, H BU 15254,I/A 14 (30.12.21).
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datosregistrales. T 775, L 566, F 2, S 8, H BU 15254, I/A 15 (30.12.21).
20 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PASCUAL SANTOS JESUS. Consejero: PASCUAL SANTOS JESUS;SANZ GIMENEZ RICOFERNANDO;BLANCO SANTO TOMAS CRISTINA. Presidente: PASCUAL SANTOS JESUS. Vicepresid.: SANZ GIMENEZ RICOFERNANDO. Nombramientos. Consejero: PASCUAL SANTOS JESUS. Presidente: PASCUAL SANTOS JESUS. Consejero:PRADO MEDIAVILLA MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: PRADO MEDIAVILLA MIGUEL ANGEL. Consejero: BLANCO SANTO TOMASCRISTINA. Datos registrales. T 672, L 463, F 177, S 8, H BU 15254, I/A 12 (14.08.20).
Nombramientos. Con.Delegado: PASCUAL SANTOS JESUS. Datos registrales. T 775, L 566, F 1, S 8, H BU 15254, I/A 13(14.08.20).
14 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 672, L 463, F 177, S 8, H BU 15254, I/A 11 ( 8.07.20).
26 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 672, L 463, F 177, S 8, H BU 15254, I/A 10 (20.08.19).
29 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTOLIN TOLEDANO JOSE;ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO;TEMI脩O ESTEFANIA JOSE MANUEL.Presidente: ANTOLIN TOLEDANO JOSE. Vicepresid.: ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO. Cons.Del.Sol: ANTOLIN TOLEDANOJOSE;ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO. Nombramientos. Consejero: PASCUAL SANTOS JESUS;SANZ GIMENEZ RICOFERNANDO;BLANCO SANTO TOMAS CRISTINA. Presidente: PASCUAL SANTOS JESUS. Vicepresid.: SANZ GIMENEZ RICOFERNANDO. Datos registrales. T 672, L 463, F 176, S 8, H BU 15254, I/A 8 (23.08.17).
Nombramientos. Con.Delegado: PASCUAL SANTOS JESUS. Datos registrales. T 672, L 463, F 177, S 8, H BU 15254, I/A 9(23.08.17).
18 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 672, L 463, F 176, S 8, H BU 15254, I/A 7 (12.01.17).
20 de Junio de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: JUAREZ GONZALEZ JAVIER;NAVARRO NAVE EDUARDO. Nombramientos. Apo.Manc.:ARIZNAVARRETA ESTEBAN ANSELMO JAVIER;NAVARRO NAVE EDUARDO. Datos registrales. T 672, L 463, F 175, S 8, H BU15254, I/A 6 (14.06.16).
08 de Marzo de 2016Otros conceptos: Concesi贸n de incentivos regionales por el MInisterio de Hacienda y Administraciones p煤blicas, con fecha 30-12-2015. Expediente V/1283/P12. Datos registrales. T 672, L 463, F 175, S 8, H BU 15254, I/A 5/N ( 2.03.16).
02 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: ESPINOSA DE LOS MONTEROS SCHURR HERNANDO;NAVARRO NAVE EDUARDO.Nombramientos. Apo.Manc.: JUAREZ GONZALEZ JAVIER;NAVARRO NAVE EDUARDO. Datos registrales. T 672, L 463, F 175, S8, H BU 15254, I/A 5 (27.10.15).
26 de Enero de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.740.000,00 Euros. Desembolsado: 1.740.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.800.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.800.000,00 Euros. Datos registrales. T 672, L 463, F 174, S 8, H BU 15254, I/A 4 (20.01.15).
17 de Febrero de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: ESPINOSA DE LOS MONTEROS SCHURR HERNANDO;NAVARRO NAVE EDUARDO. Datos
26 de Diciembre de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 19.11.13. Objeto social: Servicios t茅cnicos destinados a la industria. Fabricaci贸n ycomercializaci贸n de piezas para industria de automoci贸n. Comercializaci贸n de todo tipo de productos. Desarrollo de t茅cnicas deinvestigaci贸n. Servicios de mediaci贸n. Tr谩fico sobre inmuebles. Participaci贸n en sociedades con objeto id茅ntico. Domicilio: CTRAMADRID-IRUN Km 244,8 (BURGOS). Capital suscrito: 60.000,00 Euros. Desembolsado: 60.000,00 Euros. Declaraci贸n deunipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA. Nombramientos. Consejero: ANTOLIN TOLEDANOJOSE;ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO;TEMI脩O ESTEFANIA JOSE MANUEL. Presidente: ANTOLIN TOLEDANO JOSE. Vicepresid.:ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO. Secretario: RUIZ FERREIRO PABLO. Vicesecret.: MARTINEZ SAENZ DE JUBERA AZUCENA.Datos registrales. T 672, L 463, F 171, S 8, H BU 15254, I/A 1 (19.12.13).
Nombramientos. Cons.Del.Sol: ANTOLIN TOLEDANO JOSE;ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO. Datos registrales. T 672, L 463, F174, S 8, H BU 15254, I/A 2 (19.12.13).