Actos BORME de Grupo Delifactory Sl
13 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4496 , F 7, S 8, H Z 57731, I/A 25 ( 3.11.23).
10 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4135 , F 69, S 8, H Z 57731, I/A 24 ( 2.11.23).
11 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: MURILLO LETOSA SHEILA. Datos registrales. T 4135 , F 68, S 8, H Z 57731, I/A 22 ( 4.03.22).
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ BOUDET PEDRO ALVARO. Datos registrales. T 4135 , F 69, S 8, H Z 57731, I/A 23 ( 4.03.22).
09 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: LUENGO EGIDO JAVIER. Datos registrales. T 4135 , F 68, S 8, H Z 57731, I/A 21 ( 2.02.22).
20 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Datos registrales. T 4135 ,F 68, S 8, H Z 57731, I/A 19 (13.10.21).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO EGIDO GUILLERMO. Cons.Del.Sol: LUENGO EGIDO GUILLERMO. Nombramientos.Consejero: LUENGO EGIDO JAVIER. Presidente: LUENGO EGIDO JAVIER. Cons.Del.Sol: LUENGO EGIDO JAVIER. Reelecciones.Secretario: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Otros conceptos: Cambiado el representante del consejero SA MINERA CATALANOARAGONESA. Datos registrales. T 4135 , F 68, S 8, H Z 57731, I/A 20 (13.10.21).
09 de Agosto de 2021Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4135 , F 67, S 8, H Z57731, I/A 18 ( 2.08.21).
27 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4135 , F 67, S 8, H Z 57731, I/A 17 (20.07.21).
31 de Diciembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 393.155,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.401.905,00 Euros. Datos registrales. T 4135 , F 66, S 8, HZ 57731, I/A 16 (20.12.19).
16 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: LOPEZ BOUDET PEDRO ALVARO. Datos registrales. T 4135 , F 66, S 8, H Z 57731, I/A 15 (5.12.19).
14 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: AZON PUERTOLAS EVA MARIA. Datos registrales. T 4082 , F 80, S 8, H Z 57731, I/A 12 ( 7.10.19).
Nombramientos. Apoderado: GIMENO PUYOL MIGUEL ANGEL. Otros conceptos: Nombrado para el cargo de Director FinancieroDon Miguel Angel Gimeno Puyol. DNI 25.443.525-M. Datos registrales. T 4082 , F 80, S 8, H Z 57731, I/A 13 ( 7.10.19).
Nombramientos. Apoderado: MIRANDA GOMEZ JOSE ANTONIO. Dir. General: MIRANDA GOMEZ JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 4135 , F 64, S 8, H Z 57731, I/A 14 ( 7.10.19).
29 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: PEREZ-ARAMENDIA VIDAL CARLOS-JAVIER. Datos registrales. T 4082 , F 80, S 8, H Z 57731, I/A 11(22.08.19).
18 de Octubre de 2018Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 4082 , F 80, S 8, H Z57731, I/A 10 (10.10.18).
22 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: LUENGO EGIDO JAVIER. Datos registrales. T 4082 , F 79, S 8, H Z 57731, I/A 9 (14.03.17).
23 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO EGIDO JAVIER. Presidente: LUENGO EGIDO JAVIER. Consejero: FRAJ GASCONMIGUEL ANGEL. Vicepresid.: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Consejero: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Secretario: MIRANDASIMAVILLA JUAN. Cons.Del.Sol: LUENGO EGIDO JAVIER;FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero:LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Secretario:FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Consejero: LUENGO EGIDO GUILLERMO. Cons.Del.Sol: LUENGO EGIDO GUILLERMO;FRAJGASCON MIGUEL ANGEL. Consejero: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Datos registrales. T 4082 , F 78, S 8, H Z 57731, I/A7 (11.11.16).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.808.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.008.750,00 Euros. Datos registrales. T 4082 , F 78, S 8,H Z 57731, I/A 8 (14.11.16).
07 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: PEREZ-ARAMENDIA VIDAL CARLOS-JAVIER. Datos registrales. T 4082 , F 77, S 8, H Z 57731, I/A6 (30.03.16).
31 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VARELA VAZQUEZ ROBERTO;GONZALEZ VARELA JOSE-LUIS. Nombramientos. Consejero:LUENGO EGIDO JAVIER. Presidente: LUENGO EGIDO JAVIER. Consejero: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: FRAJGASCON MIGUEL ANGEL. Consejero: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Secretario: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Cons.Del.Sol:LUENGO EGIDO JAVIER;FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 4082 , F 75, S 8, H Z 57731, I/A 4 (21.03.16).
Otros conceptos: Modificados 铆ntegramente los Estatutos de la Sociedad por acuerdo de la Junta General Universal de fecha 10 demarzo de 2016. Cambio de domicilio social. PASEO INDEPENDENCIA 21 3& (ZARAGOZA). Datos registrales. T 4082 , F 76, S8, H Z 57731, I/A 5 (21.03.16).
25 de Noviembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 110.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 200.250,00 Euros. Datos registrales. T 4082 , F 75, S 8, H Z57731, I/A 3 (18.11.15).
30 de Enero de 2015Cambio de domicilio social. CTRA DE LOGRO脩O 92 (UTEBO). Datos registrales. T 4082 , F 74, S 8, H Z 57731, I/A 2 (22.01.15).