Actos BORME de Grupo Hermanos Martin Sa
22 de Noviembre de 2023Reelecciones. Adm. Unico: GESTISUR GONZAMAR 2004 SL. Otros conceptos: GESTISUR GONZAMAR 2004 SL; designa comorepresentante persona f铆sica a DON VICENTE MARTIN GONZALEZ, con DNI 28.509.533-K.- Datos registrales. T 6757 , F 47, S 8, HSE 1313, I/A 47 (14.11.23).
30 de Mayo de 2023Otros conceptos: Por Resoluci贸n de la Direcci贸n General de Fondos Europeos, se concede la MODIFICACION DE LA CONCESIONDE INCENTIVOS REGIONALES Exp. SE/1627/P08, siendo tal modificaci贸n sobre el PLAZO de vigencia establecido en el apartado 2.9de la resoluci贸n individual, el cual FINALIZARA EL 16/07/2024. Datos registrales. T 6757 , F 47, S 8, H SE 1313, I/A 46 (22.05.23).
15 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: NETADIA EUROPA SLP. Datos registrales. T 6757 , F 46, S 8, H SE 1313, I/A 45 ( 8.02.23).
02 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUIMEDES SLP. Datos registrales. T 6757 , F 46, S 8, H SE 1313, I/A44 (27.01.22).
26 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUIMEDES SLP. Datos registrales. T 6757 , F 45, S 8, H SE 1313, I/A42 (18.02.21).
03 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: LOZANO MENA ANTONIO. Apo.Sol.: CALADO LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 6757 , F 45, S 8,H SE 1313, I/A 41 (25.11.20).
11 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUIMEDES SLP. Datos registrales. T 6757 , F 44, S 8, H SE 1313, I/A40 ( 3.02.20).
07 de Enero de 2020Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GESTISUR GONZAMAR 2004 S.L. Y COMPA脩IA SOCIEDAD CO. Datosregistrales. T 6757 , F 39, S 8, H SE 1313, I/A 38 (26.12.19).
Fusi贸n por uni贸n. Sociedades que se fusi贸nan: DISTRIBUCION Y ENVASADOS DE ALIMENTACION HERMANOS. Datosregistrales. T 6757 , F 39, S 8, H SE 1313, I/A 39 (26.12.19).
23 de Agosto de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 21.035,35 Euros. Desembolsado: 21.035,35 Euros. Resultante Suscrito: 1.523.565,61 Euros.Resultante Desembolsado: 1.523.565,61 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Fusi贸npor uni贸n. Sociedades que se fusi贸nan: SEVILLANA DE SUPERMERCADOS SL. SUPERMERCADOS MARTIN SL. Datosregistrales. T 4104 , F 127, S 8, H SE 1313, I/A 37 (14.08.19).
08 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUIMEDES SLP. Datos registrales. T 4104 , F 127, S 8, H SE 1313, I/A36 (30.01.19).
01 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTIN RODRIGUEZ JERONIMO. Datos registrales. T 4104 , F 126, S 8, H SE 1313, I/A 35(24.01.19).
04 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN GONZALEZ JULIO. Secretario: MARTIN GONZALEZ JULIO. Consejero: MARTINGONZALEZ VICENTE;MARTIN GONZALEZ JUSTO. Cons.Del.Sol: MARTIN GONZALEZ VICENTE. Presidente: MARTIN GONZALEZVICENTE. Consejero: MARTIN RODRIGUEZ JERONIMO. Nombramientos. Adm. Unico: GESTISUR GONZAMAR 2004 SL.Modificaciones estatutarias. 7. Art铆culo 7潞 La Sociedad ser谩 regida, administrada y representada por un administrador 煤nico.".Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T4104 , F 126, S 8, H SE 1313, I/A 34 (20.11.18).
23 de Mayo de 2018Reelecciones. Auditor: SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUIMEDES SLP. Datos registrales. T 4104 , F 125, S 8, H SE 1313, I/A33 (15.05.18).
13 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN GONZALEZ JERONIMO. Presidente: MARTIN GONZALEZ JERONIMO. Cons.Del.Sol:MARTIN GONZALEZ JERONIMO. Nombramientos. Presidente: MARTIN GONZALEZ VICENTE. Consejero: MARTIN RODRIGUEZJERONIMO. Datos registrales. T 4104 , F 125, S 8, H SE 1313, I/A 32 ( 2.03.18).
21 de Febrero de 2017Reelecciones. Auditor: SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUIMEDES SLP. Datos registrales. T 4104 , F 41, S 8, H SE 1313, I/A31 ( 7.02.17).
02 de Marzo de 2016Reelecciones. Auditor: SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUIMEDES SLP. Datos registrales. T 4104 , F 41, S 8, H SE 1313, I/A30 (22.02.16).
01 de Octubre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GONZALEZ JULIO;MARTIN GONZALEZ JUSTO. Reelecciones. Consejero: MARTINGONZALEZ JERONIMO. Presidente: MARTIN GONZALEZ JERONIMO. Consejero: MARTIN GONZALEZ JULIO. Secretario: MARTINGONZALEZ JULIO. Consejero: MARTIN GONZALEZ VICENTE;MARTIN GONZALEZ JUSTO. Cons.Del.Sol: MARTIN GONZALEZJERONIMO;MARTIN GONZALEZ VICENTE. Datos registrales. T 4104 , F 40, S 8, H SE 1313, I/A 29 (23.09.15).
27 de Marzo de 2015Reelecciones. Auditor: SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUIMEDES SLP. Datos registrales. T 4104 , F 39, S 8, H SE 1313, I/A28 (20.03.15).
17 de Octubre de 2014Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. Explotaci贸n de gimnasios einstalaciones deportivas. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MAS SPORT GIMARGON SL. Datos registrales. T 3145 ,F 55, S 8, H SE 1313, I/A 26 ( 7.10.14).
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 2潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- .Cambio de objeto social. 1.- El almacenamiento y explotaci贸n comercial de autoservicios de alimentaci贸n, droguer铆a y menaje, as铆como la venta al mayor de dichos productos, y el alquiler de maquinarias, expositores, vitrinas, balanzas y cualquier otro bien mueblenecesario para la explotaci贸n de autoservicios de alimentaci贸. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MAS SPADEL GYMSOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4104 , F 37, S 8, H SE 1313, I/A 27 ( 9.10.14).
17 de Mayo de 2012Revocaciones. Auditor: ALFARO LOPEZ FERNANDO;MEDINA RUBIO AFRICA. Nombramientos. Auditor: SERVICIOSEMPRESARIALES ARQUIMEDES SLP. Datos registrales. T 3145 , F 55, S 8, H SE 1313, I/A 25 (27.04.12).
12 de Abril de 2011Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Cambio de objeto social. El almacenamiento y explotaci贸ncomercial de autoservicios de art铆culos dealimentaci贸n, droguer铆a y menaje, as铆 como la venta al mayor de dichos productos, y elalquiler de maquinarias, expositores, vitrinas, balanzas y cualquier otro bien mueble necesario para la explotaci贸n de autoservicios deal. Datos registrales. T 3145 , F 55, S 8, H SE 1313, I/A 24 ( 1.04.11).
15 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN GONZALEZ JERONIMO. Presidente: MARTIN GONZALEZ JERONIMO. Consejero: MARTINGONZALEZ JULIO. Secretario: MARTIN GONZALEZ JULIO. Consejero: MARTIN GONZALEZ JUSTO;MARTIN GONZALEZ VICENTE.Cons.Del.Sol: MARTIN GONZALEZ JERONIMO;MARTIN GONZALEZ VICENTE. Revocaciones. Apo.Sol.: DOMINGUEZ CARDOSOJAVIER;DIAZ JIMENEZ MATILDE. Nombramientos. Consejero: MARTIN GONZALEZ JERONIMO. Presidente: MARTIN GONZALEZJERONIMO. Consejero: MARTIN GONZALEZ JULIO. Secretario: MARTIN GONZALEZ JULIO. Consejero: MARTIN GONZALEZVICENTE;MARTIN GONZALEZ JUSTO. Cons.Del.Sol: MARTIN GONZALEZ JERONIMO;MARTIN GONZALEZ VICENTE. Apo.Sol.:MARTIN GONZALEZ JULIO;MARTIN GONZALEZ JUSTO;CALADO LOPEZ MANUEL;RONCERO RODRIGUEZ JESUS. Datosregistrales. T 3145 , F 53, S 8, H SE 1313, I/A 23 ( 2.11.10).
03 de Marzo de 2010Nombramientos. Auditor: ALFARO LOPEZ FERNANDO;MEDINA RUBIO AFRICA. Datos registrales. T 3145 , F 52, S 8, H SE1313, I/A 22 (12.02.10).
23 de Octubre de 2009Reelecciones. Auditor: ACOVE AUDITORES SL. Datos registrales. T 3145 , F 52, S 8, H SE 1313, I/A 21 ( 6.10.09).