Buscador CIF Logo

Actos BORME Grupo Internacional Del Mueble Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Grupo Internacional Del Mueble Sa

Actos BORME Grupo Internacional Del Mueble Sa - A30632921

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Grupo Internacional Del Mueble Sa con CIF A30632921

馃敊 Perfil de Grupo Internacional Del Mueble Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Grupo Internacional Del Mueble Sa

20 de Abril de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROBERTO HERNANDEZ LEON. Nombramientos. Consejero: HECTOR FUENTE MANSILLA.Datos registrales. T 3573 , F 24, S 8, H MU 4285, I/A 43 (13.04.23).

24 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: JULIO GARCIA RAMOS. Datos registrales. T 3573 , F 24, S 8, H MU 4285, I/A 42 (17.08.22).

01 de Abril de 2022
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.490,92 Euros. Resultante Suscrito: 171.739,22 Euros. Datos registrales. T 3147 , F 4, S

Otros conceptos: Modifican el articulo 12潞 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 3147 , F 4, S 8, H MU 4285, I/A 41(25.03.22).

02 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Consejero: VICENT VERDU IBA脩EZ;ROBERTO HERNANDEZ LEON;FELIPE MIGUEL BACALLADO MENA;JAVIERANTONIO MOYA POZO;JULIO GARCIA RAMOS. Presidente: JULIO GARCIA RAMOS. Consejero: FRANCISCO-JAVIERDOMINGUEZ LOPEZ. Vicepresid.: VICENT VERDU IBA脩EZ. Secretario: JAVIER ANTONIO MOYA POZO. Datos registrales. T 3147, F 3, S 8, H MU 4285, I/A 38 (26.08.19).

Nombramientos. Apoderado: JULIO GARCIA RAMOS. Datos registrales. T 3147 , F 3, S 8, H MU 4285, I/A 39 (26.08.19).

28 de Noviembre de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 16.227,33 Euros. Resultante Suscrito: 178.230,14 Euros. Datos registrales. T 3147 , F 3,S 8, H MU 4285, I/A 37 (21.11.18).

15 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BENILDE PELEGRI CUENCA. Datos registrales. T 3147 , F 3, S 8, H MU 4285, I/A 36 ( 7.11.18).

01 de Septiembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: MANUEL VICTOR CIRIA CALVO. Datos registrales. T 3147 , F 3, S 8, H MU 4285, I/A 35 (25.08.17).

21 de Diciembre de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 11.809,88 Euros. Resultante Suscrito: 194.457,47 Euros. Datos registrales. T 3147 , F 2,S 8, H MU 4285, I/A 34 (14.12.16).

01 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ISABEL MARIA URIBARRI NAVARRO;MANUEL VICTOR CIRIA CALVO. Presidente: JESUSMORCILLO GARCINU脩O. Vicepresid.: ISABEL MARIA URIBARRI NAVARRO. Secretario: MANUEL VICTOR CIRIA CALVO.Revocaciones. Apo.Sol.: MANUEL VICTOR CIRIA CALVO;JESUS MORCILLO GARCINU脩O. Nombramientos. Apoderado: JULIOGARCIA RAMOS. Consejero: JULIO GARCIA RAMOS. Presidente: JULIO GARCIA RAMOS. Consejero: FRANCISCO-JAVIERDOMINGUEZ LOPEZ;BENILDE PELEGRI CUENCA. Vicepresid.: VICENT VERDU IBA脩EZ. Secretario: JAVIER ANTONIO MOYAPOZO. Datos registrales. T 3147 , F 2, S 8, H MU 4285, I/A 33 (25.08.16).

24 de Junio de 2016
Nombramientos. Apoderado: JAVIER ANTONIO MOYA POZO. Datos registrales. T 3147 , F 1, S 8, H MU 4285, I/A 32 (17.06.16).

19 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: JULIAN SERRANO ROMERO DE AVILA;ISABEL MARIA URIBARRI NAVARRO;MANUEL VICTORCIRIA CALVO;VICENT VERDU IBA脩EZ;JESUS MORCILLO GARCINU脩O;ADRIAN GARCIA GONZALEZ;FELIPE MIGUELBACALLADO MENA;JAVIER ANTONIO MOYA POZO. Presidente: JULIAN SERRANO ROMERO DE AVILA. Vicepresid.: ISABELMARIA URIBARRI NAVARRO. Secretario: MANUEL VICTOR CIRIA CALVO. Revocaciones. Apoderado: JULIAN SERRANOROMERO DE AVILA. Nombramientos. Consejero: JESUS MORCILLO GARCINU脩O;ISABEL MARIA URIBARRINAVARRO;MANUEL VICTOR CIRIA CALVO;VICENT VERDU IBA脩EZ;ROBERTO HERNANDEZ LEON;FELIPE MIGUELBACALLADO MENA;JAVIER ANTONIO MOYA POZO. Presidente: JESUS MORCILLO GARCINU脩O. Vicepresid.: ISABEL MARIAURIBARRI NAVARRO. Secretario: MANUEL VICTOR CIRIA CALVO. Apo.Sol.: MANUEL VICTOR CIRIA CALVO;JESUS MORCILLOGARCINU脩O. Otros conceptos: Modifican el articulo 12潞 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 3147 , F 1, S 8, H MU4285, I/A 31 (12.01.16).

20 de Octubre de 2015
Revocaciones. Apoderado: JOSE MANUEL COCA脩A FERNANDEZ. Nombramientos. Apoderado: MANUEL VICTOR CIRIACALVO. Datos registrales. T 2261 , F 202, S 8, H MU 4285, I/A 30 (13.10.15).

11 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE MANUEL COCA脩A FERNANDEZ;ISABEL URIBARRI NAVARRO;MANUEL CIRIACALVO;RAQUEL MARIA HERNANDEZ MORENO;JULIAN SERRANO ROMERO;RAMON AGUSTIN DIAZ DIAZ;JOSE MARIA LOPEZFRANCO. Presidente: JOSE MANUEL COCA脩A FERNANDEZ. Vicepresid.: ISABEL URIBARRI NAVARRO. Secretario: MANUELCIRIA CALVO. Con.Delegado: JULIAN SERRANO ROMERO. Nombramientos. Consejero: JULIAN SERRANO ROMERO DEAVILA;ISABEL MARIA URIBARRI NAVARRO;MANUEL VICTOR CIRIA CALVO;VICENT VERDU IBA脩EZ;JESUS MORCILLOGARCINU脩O;ADRIAN GARCIA GONZALEZ;FELIPE MIGUEL BACALLADO MENA;JAVIER ANTONIO MOYA POZO. Presidente:JULIAN SERRANO ROMERO DE AVILA. Vicepresid.: ISABEL MARIA URIBARRI NAVARRO. Secretario: MANUEL VICTOR CIRIACALVO. Apoderado: JULIAN SERRANO ROMERO DE AVILA. Datos registrales. T 2261 , F 202, S 8, H MU 4285, I/A 29 ( 4.02.15).

29 de Mayo de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.490,93 Euros. Resultante Suscrito: 206.267,35 Euros. Datos registrales. T 2261 , F 201,S 8, H MU 4285, I/A 28 (21.05.12).

03 de Agosto de 2011
Revocaciones. Apoderado: JULIO GARCIA RAMOS. Datos registrales. T 2261 , F 201, S 8, H MU 4285, I/A 27 (22.07.11).

21 de Julio de 2011
Nombramientos. Apoderado: JOSE MANUEL COCA脩A FERNANDEZ. Datos registrales. T 2261 , F 200, S 8, H MU 4285, I/A 25(13.07.11).

10 de Marzo de 2011
Fe de erratas: El nombre correcto del Consejero designado es Julian Serrano Romero, con NIF 52.131.905-J, y no Julian SerranoMoreno como se publico por error.Se publico por error el apellido del Consejero Delegado Don Julian Serrano Moreno, siendo elcorrecto Don Julian Serrano Romero, con NIF 52.131.905-J. Datos registrales. T 2261 , F 200, S 8, H MU 4285, I/A 24 (24.12.10).

03 de Enero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: JULIO GARCIA RAMOS;LOURDES DAMIAN COSANO;JOSE MATEO NEVADO MEDINA;JUANFRANCISCO CORRAL AGUADO;FELIPE BACALLADO MENA;MANUEL RUBIO PUIG;JESUS NEBRA MINGUEZ;ALBERTO ALBERTVERDU;MANUEL MARTIN ESCOBAR;JUAN CARLOS OLIVA CARO;LUIS CARLOS LORENTE OSCOZ;SABINO MARTINEZESPASINDE. Presidente: JULIO GARCIA RAMOS. Vicepresid.: LOURDES DAMIAN COSANO. Secretario: JOSE MATEO NEVADOMEDINA. Con.Delegado: JOSE MATEO NEVADO MEDINA. Nombramientos. Consejero: JOSE MANUEL COCA脩AFERNANDEZ;ISABEL URIBARRI NAVARRO;MANUEL CIRIA CALVO;RAQUEL MARIA HERNANDEZ MORENO;JULIAN SERRANOMORENO;RAMON AGUSTIN DIAZ DIAZ;JOSE MARIA LOPEZ FRANCO. Presidente: JOSE MANUEL COCA脩A FERNANDEZ.Vicepresid.: ISABEL URIBARRI NAVARRO. Secretario: MANUEL CIRIA CALVO. Con.Delegado: JULIAN SERRANO MORENO.Datos registrales. T 2261 , F 200, S 8, H MU 4285, I/A 24 (24.12.10).

09 de Octubre de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.769,72 Euros. Resultante Suscrito: 212.758,28 Euros. Datos registrales. T 2261 , F 200,S 8, H MU 4285, I/A 23 (30.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n