Buscador CIF Logo

Actos BORME Grupo Isolux Corsan Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Grupo Isolux Corsan Sa

Actos BORME Grupo Isolux Corsan Sa - A84173947

Tenemos registrados 174 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Grupo Isolux Corsan Sa con CIF A84173947

馃敊 Perfil de Grupo Isolux Corsan Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Grupo Isolux Corsan Sa

31 de Agosto de 2020
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1304/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 12/03/2020. Auto de conclusi贸n delconcurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOSNIETO DELGADO. Resoluciones: Auto por el que se acuerda la conclusion del concurso por insuficiencia de masa.activa cesando lasfacultades de administracion. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1304/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 12/03/2020.Cese de las limitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DEMADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. Fecha de resoluci贸n12/07/2017. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 1 DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON CARLOSNIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 12/03/2020, NIF/CIF B65793879. DATA CONCURSAL SLP. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 700/2017. Fecha de resoluci贸n 17/07/2017. Revocaci贸n de administradores concursales.Juzgado: num. 1 DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON CARLOS NIETO DELGADO. Auxiliar Delegado Concursal. Fecha12/03/2020, NIF/CIF B86346160. LEGAL Y ECONOMICO-ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP. Extinci贸n. Datosregistrales. T 36514 , F 77, S 8, H M 367466, I/A 233 (24.08.20).

10 de Febrero de 2020
Reelecciones. Consejero: FUSTER & PARTNERS ASESORES SL;PASTOR GARCIA DAVID;VILELLA SILLA DAVID. Presidente:PASTOR GARCIA DAVID. Vicepresid.: VILELLA SILLA DAVID. Cons.Del.Sol: PASTOR GARCIA DAVID;VILELLA SILLADAVID;FUSTER & PARTNERS ASESORES SL. Representan: MEDINA FERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 36514 , F 76,S 8, H M 367466, I/A 232 ( 3.02.20).

25 de Octubre de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 12/09/2018. Resoluci贸n judicial deacumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Datos registrales. T 35408 , F214, S 8, H M 367466, I/A A--M (18.10.19).

24 de Octubre de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 261/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 18/09/2019. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Datosregistrales. T 36514 , F 76, S 8, H M 367466, I/A B (17.10.19).

22 de Octubre de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018. Resoluci贸n judicial deacumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Datos registrales. T 35408 , F79, S 8, H M 367466, I/A A-M4 (15.10.19).

16 de Agosto de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 261/2018. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO.Resoluciones: CONVERSION EN INSCRIPCION de la Anotaci贸n Preventiva letra A, por FIRMEZA DEL AUTO dictado el 31 deOctubre de 2018.- Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 261/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018.Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado:num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Datos registrales. T 35408 , F78, S 8, H M 367466, I/A AM2 ( 8.08.19).

Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 261/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO.Resoluciones: CONVERSION EN INSCRIPCION de la Anotaci贸n Preventiva letra A, por FIRMEZA DEL AUTO dictado el 31 deOctubre de 2018.- Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 261/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018.Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado:num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Datos registrales. T 35408 , F78, S 8, H M 367466, I/A A-M3 ( 8.08.19).

31 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: AVILA ALVAREZ FEDERICO. Apo.Sol.: AVILA ALVAREZ FEDERICO. Apo.Manc.: AVILA ALVAREZFEDERICO. Datos registrales. T 36514 , F 76, S 8, H M 367466, I/A 230 (24.05.19).

Revocaciones. Apoderado: AGUILERA RIOS FRANCISCO. Apo.Man.Soli: AGUILERA RIOS FRANCISCO. Datos registrales. T36514 , F 76, S 8, H M 367466, I/A 231 (24.05.19).

29 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: MARTIN FRANCISCO DAMIAN DOROTEO. Datos registrales. T 36514 , F 75, S 8, H M 367466, I/A229 (22.05.19).

01 de Abril de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018. Resoluci贸n judicial deacumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Datos registrales. T 35408 , F77, S 8, H M 367466, I/A A-M1 (25.03.19).

Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018. Resoluci贸n judicial deacumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Datos registrales. T 35408 , F78, S 8, H M 367466, I/A A-M2 (25.03.19).

08 de Marzo de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 17/07/2017. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CRISTINA POUSA BLASCO.Resoluciones: FIRMEZA DEL AUTO DE DECLARACION DE CONCURSO DE FECHA 12/07/2017. Datos registrales. T 36514 , F 75,S 8, H M 367466, I/A 228 ( 1.03.19).

08 de Enero de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 12/09/2018. Resoluci贸n judicial deacumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: DON CARLOS NIETODELGADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 12/09/2018. Resoluci贸njudicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: DON CARLOSNIETO DELGADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 12/09/2018.Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez:DON CARLOS NIETO DELGADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n12/09/2018. Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE

04 de Enero de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018. Resoluci贸n judicial deacumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: DON CARLOS NIETODELGADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018. Resoluci贸njudicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: DON CARLOSNIETO DELGADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018.Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez:DON CARLOS NIETO DELGADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n31/10/2018. Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DEMADRID. Juez: DON CARLOS NIETO DELGADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha deresoluci贸n 31/10/2018. Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1DE MADRID. Juez: DON CARLOS NIETO DELGADO. Datos registrales. T 35408 , F 77, S 8, H M 367466, I/A AM B (26.12.18).

27 de Diciembre de 2018
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018. Resoluci贸n judicial deacumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: DON CARLOS NIETODELGADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018. Resoluci贸njudicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: DON CARLOSNIETO DELGADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 31/10/2018.Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez:DON CARLOS NIETO DELGADO. Datos registrales. T 35408 , F 77, S 8, H M 367466, I/A A-M (19.12.18).

18 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRUZ CRUZ BEGO脩A;MIGUEL GONZALEZ ESTEBAN;ROPERO GARCIA JOSE MANUEL;PEREZQUESADA JUAN MANUEL;AGUILERA RIOS FRANCISCO;REINA PINTO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 36514 , F 73, S 8, HM 367466, I/A 227 (10.12.18).

13 de Diciembre de 2018
Cambio de domicilio social. AVDA MANOTERAS 18 (MADRID). Datos registrales. T 36514 , F 72, S 8, H M 367466, I/A 225 (4.12.18).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 36514 , F 73, S 8, H M 367466, I/A 226 ( 4.12.18).

01 de Junio de 2018
Nombramientos. Apoderado: CRUZ CRUZ BEGO脩A;ROMAN BEDMAR AGUSTIN;MIGUEL GONZALEZ ESTEBAN;AGUILERARIOS FRANCISCO;ROPERO GARCIA JOSE MANUEL;PEREZ QUESADA JUAN MANUEL;REINA PINTO JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 36514 , F 72, S 8, H M 367466, I/A 224 (24.05.18).

04 de Mayo de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 36514 , F 72, S 8, H M 367466, I/A 223 (24.04.18).

03 de Abril de 2018
Otros conceptos: Derogaci贸n del Reglamento del Consejo de Administraci贸n, que fue aprobado por acuerdo del Consejo deAdministraci贸n el 14 de diciembre de 2016. Datos registrales. T 36514 , F 71, S 8, H M 367466, I/A 222 (22.03.18).

11 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: CRUZ CRUZ BEGO脩A;SERRANO SANCHEZ FERNANDO;LEBRERO BURGOS FRANCISCOJAVIER;MIGUEL GONZALEZ LUIS ESTEBAN. Datos registrales. T 36514 , F 71, S 8, H M 367466, I/A 221 (29.11.17).

22 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: CASADO MARCOS ESTHER. Datos registrales. T 35408 , F 100, S 8, H M 367466, I/A 220(14.11.17).

20 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPARZA TORRECILLA JESUS. Apo.Manc.: AVILA ALVAREZ FEDERICO;REINA PINTO JUANCARLOS;CRUZ CRUZ BEGO脩A;LEBRERO BURGOS FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 35408 , F 93, S 8, H M 367466,I/A 217 ( 8.11.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: OLESTI LUNA JORGE ENRIQUE. Apo.Manc.: ESPARZA TORRECILLA JESUS;REINA PINTO JUANCARLOS;CRUZ CRUZ BEGO脩A;MIGUEL GONZALEZ ESTEBAN. Datos registrales. T 35408 , F 96, S 8, H M 367466, I/A 218 (8.11.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRUZ CRUZ BEGO脩A;LEBRERO BURGOS FRANCISCO-JAVIER;MIGUEL GONZALEZ ESTEBAN.Datos registrales. T 35408 , F 98, S 8, H M 367466, I/A 219 ( 8.11.17).

10 de Octubre de 2017
Nombramientos. Cons.Del.Sol: PASTOR GARCIA DAVID;VILELLA SILLA DAVID;FUSTER & PARTNERS ASESORES SL. Datosregistrales. T 35408 , F 93, S 8, H M 367466, I/A 216 (29.09.17).

05 de Octubre de 2017
Otros conceptos: Se acuerda aprobar el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. Datos registrales. T35408 , F 86, S 8, H M 367466, I/A 215 (28.09.17).

04 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA NEMESIO. Cons.Ext.Ind: SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ ANGEL;GARCIA PERI ALVAREZ CRISTINA;PLAZA ARREGUI ANA;RODRIGUEZ REY ALEGRIAFRANCISCO;ZORNOZA PEREZ JUAN;CARRETERO MANZANO JAVIER. Presidente: FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENANEMESIO. MiemComAuCnt: PLAZA ARREGUI ANA;SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ ANGEL;ZORNOZA PEREZ JUAN.PresComAuCnt: PLAZA ARREGUI ANA. Mbro.Cte.NyR: CARRETERO MANZANO JAVIER;GARCIA-PERI ALVAREZ CRISTINA.Pdte.Cte.NyR: CARRETERO MANZANO JAVIER. Mbro.Cte.NyR: RODRIGUEZ REY ALEGRIA FRANCISCO. SecComAudit: FALCONRAVELO JUAN FRANCISCO. Secr.Com.Ret: FALCON RAVELO JUAN FRANCISCO. Con.Ind.Coor: SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ ANGEL. Representan: MEDINA FERNANDEZ ENRIQUE. Nombramientos. Representan: MEDINA FERNANDEZENRIQUE. Consejero: FUSTER & PARTNERS ASESORES SL;PASTOR GARCIA DAVID;VILELLA SILLA DAVID. Presidente:PASTOR GARCIA DAVID. Vicepresid.: VILELLA SILLA DAVID. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS9, 10, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, INCLUSION DE NUEVO ARTICULO 32, MODIFICACION DEL ARTICULO 32,MODIFICACION DEL ARTICULO 35, MODIFICACION DEL ARTICULO 38, ELIMINACION DE LOS ARTICULOS 39 Y 40, YMODIFICACION DEL ARTICULO 41 . Datos registrales. T 35408 , F 78, S 8, H M 367466, I/A 214 (27.09.17).

16 de Agosto de 2017
Nombramientos. Representan: VERA VAZQUEZ FRANCISCO;MARTIN MOLINA PEDRO BAUTISTA. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 700/2017. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 12/07/2017. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario.Juzgado: num. 1 DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: Los deudores conservar谩nlas facultades de administraci贸n y disposici贸n sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de 茅stas a la intervenci贸n de losadministradores concursales mediante su autorizaci贸n o conformidad. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 700/2017.Fecha de resoluci贸n 12/07/2017. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DONCARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 12/07/2017, NIF/CIF B65793879. DATA CONCURSAL SLP. AuxiliarDelegado Concursal. Fecha 17/07/2017, NIF/CIF B86346160. LEGAL Y ECONOMICO-ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP.Datos registrales. T 35408 , F 77, S 8, H M 367466, I/A A ( 7.08.17).

08 de Junio de 2017
Nombramientos. Mbro.Cte.NyR: RODRIGUEZ REY ALEGRIA FRANCISCO. Datos registrales. T 35408 , F 76, S 8, H M 367466,I/A 213 (31.05.17).

06 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Cons.Ext.Ind: ANCHUELO CREGO ALVARO. Mbro.Cte.NyR: ANCHUELO CREGO ALVARO. Datos registrales.T 35408 , F 76, S 8, H M 367466, I/A 212 (30.05.17).

18 de Abril de 2017
Revocaciones. Apoderado: DELSO HERAS LUIS;GOMIS CA脩ETE JOSE. Datos registrales. T 35408 , F 76, S 8, H M 367466, I/A210 ( 5.04.17).

Nombramientos. Apoderado: LAYOS PARDO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 35408 , F 76, S 8, H M 367466, I/A 211 (5.04.17).

09 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: PORTELA ALVAREZ ANTONIO. Con.Delegado: PORTELA ALVAREZ ANTONIO. Datosregistrales. T 35408 , F 76, S 8, H M 367466, I/A 209 (31.01.17).

23 de Enero de 2017
Otros conceptos: Emisi贸n de Warrants A.1A. Datos registrales. T 35235 , F 96, S 8, H M 367466, I/A 203 (13.01.17).

Otros conceptos: EMISION DE WARRANTS CONVERTIBLES C. Datos registrales. T 35235 , F 99, S 8, H M 367466, I/A 204(13.01.17).

Otros conceptos: Emisi贸n de Bonos C convertibles. Datos registrales. T 35408 , F 61, S 8, H M 367466, I/A 205 (13.01.17).

Otros conceptos: EMISION WARRANT GLOBAL ACCIONES. Datos registrales. T 35408 , F 64, S 8, H M 367466, I/A 206(13.01.17).

Otros conceptos: EMISION DE BONOS TRAMO B. Datos registrales. T 35408 , F 70, S 8, H M 367466, I/A 207 (16.01.17).

Otros conceptos: EMISION DE BONOS C NO CONVERTIBLES. Datos registrales. T 35408 , F 73, S 8, H M 367466, I/A 208(16.01.17).

17 de Enero de 2017
Otros conceptos: Aprobaci贸n de un nuevo Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Derogado el Reglamento del Consejo deAdministraci贸n aprobado el 15 de enero de 2015. Datos registrales. T 35235 , F 89, S 8, H M 367466, I/A 202 (10.01.17).

13 de Enero de 2017
Revocaciones. Apoderado: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO. Datos registrales. T 35235 , F 89, S 8, H M 367466, I/A 201( 5.01.17).

12 de Enero de 2017
Modificaciones estatutarias. 6. Capital social.-. 8. Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.-. 10. Organos de la Sociedad. 12.Competencias de la Junta General. 13. Convocatoria de la Junta General. 14. Anuncio Convocatoria. 22. Mesa de la Junta General. 23.Modo de deliberar la Junta General. 24. Adopci贸n de acuerdos. Otros conceptos: Se acuerda aprobar el reglamento de la JuntaGeneral de Accionistas de la Sociedad. Datos registrales. T 35235 , F 78, S 8, H M 367466, I/A 200 ( 3.01.17).

29 de Diciembre de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 12.611.900,84 Euros. Resultante Suscrito: 5.405.100,36 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 57.708.840,00 Euros. Desembolsado: 57.708.840,00 Euros. Resultante Suscrito: 63.113.940,36 Euros. ResultanteDesembolsado: 63.113.940,36 Euros. Otros conceptos: Desdoblamiento de acciones por reducci贸n de su valor nominal. Datosregistrales. T 35235 , F 73, S 8, H M 367466, I/A 199 (21.12.16).

20 de Diciembre de 2016
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los Art铆culos 17潞, 20潞, 29潞y 38潞 y aprobaci贸n de nuevo Texto Refundido de los EstatutosSociales.. Otros conceptos: DEROGACION DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Datos registrales.T 34981 , F 87, S 8, H M 367466, I/A 198 (13.12.16).

15 de Diciembre de 2016
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 267.552.467,82 Euros. Desembolsado: 267.552.467,82 Euros. Resultante Suscrito: 360.340.024,00Euros. Resultante Desembolsado: 360.340.024,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 342.323.022,80 Euros.Resultante Suscrito: 18.017.001,20 Euros. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n estatutaria y aprobaci贸n del nuevo textorefundido de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 34981 , F 80, S 8, H M 367466, I/A 197 ( 2.12.16).

23 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;DIAZ HINOJOSA ENRIQUE;ACEA LORENZO DAVID;PARCETHERNANDEZ EDUARDO;AVILA ALVAREZ FEDERICO;MARTINEZ ARRIBAS FERNANDO;MYRO BORRERO JOSE ENRIQUE.Datos registrales. T 34981 , F 80, S 8, H M 367466, I/A 196 (15.11.16).

25 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: CARTERA PERSEIDAS SL. MiemComAuCnt: SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZANGEL;INVERSIONES CORPORATIVAS DIGITALES SL. PresComAuCnt: SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ ANGEL. Con.Ind.:GOMEZ NAVARRO NAVARRETE JAVIER;GONZALEZ MORCILLO SERAFIN. Consj.Domini: HISCAN PATRIMONIOSA;INVERSIONES CORPORATIVAS DIGITALES SL;INVERSIONES CORPORATIVAS SA. Con.Ind.: MOURE BOURIOFRANCISCO;ROS MAORAD JOSE LUIS. Consj.Domini: SERCAPGU SL. Con.Ind.: SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ ANGEL.Cons.Ejecuti: CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL. Presidente: DELSO HERAS LUIS ANTONIO. Cons.Ejecuti: DELSO HERASLUIS ANTONIO. Vicepresid.: CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL. Representan: CASAS BEDOS JORDI;MERCADER MIROJORGE;GOMIS CA脩ETE JOSE;BELLAVISTA AULADELL FRANCESC;MARTINEZ MARQUEZ LORENZO JOSE;MALERBAALESSANDRO. Mbro.Cte.NyR: GONZALEZ MORCILLO SERAFIN;MOURE BOURIO FRANCISCO;GOMEZ-NAVARRO NAVARRETEJAVIER.Pdte.Cte.NyR: GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE JAVIER. MiemComAuCnt: ROS MAORAD JOSE LUIS. Nombramientos.Cons.Ejecuti: FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA NEMESIO. Cons.Ext.Ind: SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ ANGEL;GARCIAPERI ALVAREZ CRISTINA;PLAZA ARREGUI ANA;RODRIGUEZ REY ALEGRIA FRANCISCO;ZORNOZA PEREZ JUAN;ANCHUELOCREGO ALVARO;CARRETERO MANZANO JAVIER. Datos registrales. T 34981 , F 76, S 8, H M 367466, I/A 190 (18.10.16).

Nombramientos. Presidente: FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA NEMESIO. Datos registrales. T 34981 , F 77, S 8, H M367466, I/A 191 (18.10.16).

Nombramientos. Vicesecret.: MARTIN PERROTTO JUAN. Datos registrales. T 34981 , F 77, S 8, H M 367466, I/A 192 (18.10.16).

Nombramientos. MiemComAuCnt: PLAZA ARREGUI ANA;SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ ANGEL;ZORNOZA PEREZ JUAN.PresComAuCnt: PLAZA ARREGUI ANA. Datos registrales. T 34981 , F 77, S 8, H M 367466, I/A 193 (18.10.16).

Nombramientos. Mbro.Cte.NyR: CARRETERO MANZANO JAVIER;GARCIA-PERI ALVAREZ CRISTINA;ANCHUELO CREGOALVARO. Pdte.Cte.NyR: CARRETERO MANZANO JAVIER. Datos registrales. T 34981 , F 78, S 8, H M 367466, I/A 194 (18.10.16).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA NEMESIO. Datos registrales. T 34981 , F 78, S 8, H M367466, I/A 195 (18.10.16).

26 de Septiembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;GONZALEZ DURAN BARBARA;SANCHEZ ROJAS JUAN DEDIOS;ARIAS GONZALEZ FERNANDO;SOTO MARTINEZ JUAN JOSE;SANCHEZ LOPEZ MARIA DEL MAR. Apo.Man.Soli:TREMOLS NOBLON RAFAEL;ORTIZ DE LA TABLA GONZALEZ JOSE. Apo.Sol.: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;VALENZUELACONTRERAS COSME. Apoderado: DE GOYCOECHEA PUENTE JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli: GARCIA-PICCOLI ATANESCARLOS. Apoderado: VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apo.Man.Soli: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Apo.Manc.: GARCIAMATEOS MANUEL JOSE. Apoderado: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;VALENZUELA CONTRERAS COSME. Apo.Sol.: SANCHEZROJAS JUAN DE DIOS. Apoderado: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;ESCUDERO PEREZ ANGEL. Apo.Manc.: GARCIA MATEOSMANUEL JOSE. Apoderado: FERNANDEZ SANZ JOSE;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;GARCIA MATEOS MANUELJOSE;VALENZUELA CONTRERAS COSME;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Apo.Man.Soli: PASTRANA PASTRANA OCTAVIOFRANCISCO. Apo.Manc.: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Apo.Man.Soli: CHACON GIACOMAN RODOLFO GUILLERMO.Apoderado: HERNANDEZ MU脩OZ ANTONIO JESUS;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;DE EGA脩A HUERTA ALFONSOMIGUEL;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;PIREABARCA FERNANDO JAVIER;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apo.Sol.: HERNANDEZ MU脩OZ ANTONIO JESUS;SANCHEZROJAS JUAN DE DIOS. Apoderado: DE LOS MOZOS PASCUAL NORBERTO;SIERRA GONZALEZ JESUS;GARCIA MATEOSMANUEL JOSE;GARRIDO DE LAS HERAS JOSE;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;DEISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;GONZALEZ MARTIN JOSE JESUS;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;VALENZUELA CONTRERAS COSME. Apo.Manc.: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;PIRE ABARCA FERNANDOJAVIER;VARELA ULLASTRES SANTIAGO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;PIREABARCA FERNANDO JAVIER;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apo.Sol.: JURISTO CONTRERAS BRUNO. Apoderado: DELSORAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;GARCIAMATEOS MANUEL JOSE;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;VALENZUELA CONTRERASCOSME. Apo.Manc.: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Apo.Man.Soli: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO. Apo.Manc.:GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DELSO RAMIREZDEL MOLINO ALVARO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE.Apo.Sol.: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO. Apo.Manc.: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;ALBERTE SENDINCESAR ENRIQUE. Apoderado: ALBERTE SENDIN CESAR ENRIQUE. Apo.Manc.: ALBERTE SENDIN CESAR ENRIQUE;DELSORAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO. Apoderado: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO.Otros conceptos: QUEDAN REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS A DON MANUEL JOSE GARCIA MATEOS QUECAUSARON LAS INSCRIPCIONES 49陋 Y 91陋 DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T 34981 , F 74, S 8, H M 367466, I/A 189(16.09.16).

21 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: FRAILE RODRIGUEZ HECTOR. Datos registrales. T 34981 , F 71, S 8, H M 367466, I/A 187(14.09.16).

Nombramientos. Apoderado: AVILA ALVAREZ FEDERICO;LORENZO FERNANDEZ RAFAEL CARLOS;DELSO RAMIREZ DELMOLINO ALVARO;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;REINA PINTO JUAN CARLOS;MENDOZA BUENDIA CARLOS;SERRANOSANCHEZ FERNANDO;CRUZ CRUZ BEGO脩A;PEREZ GARCIA MARIA SANDRA;AVILA ALVAREZ FEDERICO;AVILA ALVAREZFEDERICO. Datos registrales. T 34981 , F 72, S 8, H M 367466, I/A 188 (14.09.16).

20 de Septiembre de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 34981 , F 71, S 8, H M 367466, I/A 186 (13.09.16).

05 de Septiembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO. Apo.Manc.: DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;DEISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO. Datos registrales. T 34981 , F 71, S 8, H M367466, I/A 184 (25.08.16).

Revocaciones. Apoderado: FOJO ARIAS LINO. Apo.Sol.: FOJO ARIAS LINO HUMBERTO. Datos registrales. T 34981 , F 71, S 8,H M 367466, I/A 185 (25.08.16).

01 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: FOJO ARIAS LINO HUMBERTO;CASADO MARCOS ESTHER. Datos registrales. T 34981 , F 70, S 8, HM 367466, I/A 183 (25.08.16).

09 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apoderado: ALCARAZ GARCIA IGNACIO;LORENZO FERNANDEZ RAFAEL CARLOS;GOMEZ MARTINEZCRISTIAN;REINA PINTO JUAN CARLOS;MENDOZA BUENDIA CARLOS;ALVAREZ DIAZ DE CERIO CARLOS;PEREZ GARCIASANDRA;LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 27069 , F 158, S 8, H M 367466,I/A 182 ( 1.08.16).

05 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Representan: DE TORRES ZABALA JOSE MARIA. Nombramientos. Representan: MALERBA ALESSANDRO.Datos registrales. T 27069 , F 158, S 8, H M 367466, I/A 181 (28.07.16).

12 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ TELLO ANTONIO;SANCHEZ TELLO ANTONIO. Apo.Manc.: SANCHEZ TELLOANTONIO;SANCHEZ TELLO ANTONIO. Apoderado: SANCHEZ TELLO ANTONIO;SANCHEZ TELLO ANTONIO. Apo.Manc.:SANCHEZ TELLO ANTONIO. Apo.Man.Soli: SANCHEZ TELLO ANTONIO. Apo.Manc.: SANCHEZ TELLO ANTONIO;SANCHEZTELLO ANTONIO. Datos registrales. T 27069 , F 157, S 8, H M 367466, I/A 180 ( 5.02.16).

10 de Septiembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: HERNANDEZ MANCHA ANTONIO. MiemComAuCnt: HERNANDEZ MANCHA ANTONIO. Datosregistrales. T 27069 , F 157, S 8, H M 367466, I/A 179 ( 1.09.15).

26 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ TORRALBO ANTONIO. Datos registrales. T 27069 , F 157, S 8, H M 367466, I/A 178(18.08.15).

12 de Agosto de 2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 27069 , F 157, S 8, H M 367466, I/A 177 ( 3.08.15).

30 de Junio de 2015
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GARCIA MARIA SANDRA;REINA PINTO JUAN CARLOS;LORENZO FERNANDEZ RAFAELCARLOS;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;MENDOZA BUENDIA CARLOS;ALVAREZ DIAZDE CERIO CARLOS;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A;SERRANO SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T27069 , F 154, S 8, H M 367466, I/A 176 (22.06.15).

19 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVAREZ DIAZ DE CERIO CARLOS. Apo.Manc.: REINA PINTO JUAN CARLOS;LORENZOFERNANDEZ RAFAEL CARLOS;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;MENDOZA BUENDIACARLOS. Datos registrales. T 27069 , F 152, S 8, H M 367466, I/A 175 ( 8.05.15).

08 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apoderado: VALENZUELA CONTRERAS COSME;VALENZUELA CONTRERAS COSME. Apo.Manc.: VALENZUELACONTRERAS COSME;MARTIN MORALES-CASTILLA FRANCISCO. Apoderado: VALENZUELA CONTRERASCOSME;VALENZUELA CONTRERAS COSME;VALENZUELA CONTRERAS COSME Datos registrales. T 27069 , F 152, S 8, H M367466, I/A 172 (29.04.15).

Revocaciones. Apoderado: VALGA脩ON VILLANUEVA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 27069 , F 152, S 8, H M 367466, I/A173 (29.04.15).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODERA TOBAL ANA PALOMA. Datos registrales. T 27069 , F 152, S 8, H M 367466, I/A 174(29.04.15).

06 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ ARRIBAS FERNANDO;LORENZO FERNANDEZ RAFAEL CARLOS;GOMEZ MARTINEZCRISTIAN;REINA PINTO JUAN CARLOS;MENDOZA BUENDIA CARLOS. Apoderado: MARTINEZ ARRIBAS FERNANDO.Apo.Manc.: MARTINEZ ARRIBAS FERNANDO;SERRANO SANCHEZ FERNANDO;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZBEGO脩A. Datos registrales. T 27069 , F 148, S 8, H M 367466, I/A 170 (26.02.15).

Nombramientos. Apo.Manc.: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;LORENZO FERNANDEZ RAFAEL CARLOS;GOMEZMARTINEZ CRISTIAN;REINA PINTO JUAN CARLOS;MENDOZA BUENDIA CARLOS;ALBERTE SENDIN CESAR ENRIQUE.Apoderado: ALBERTE SENDIN CESAR ENRIQUE. Apo.Manc.: ALBERTE SENDIN CESAR ENRIQUE;DELSO RAMIREZ DELMOLINO ALVARO;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A;SERRANO SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T27069 , F 150, S 8, H M 367466, I/A 171 (26.02.15).

20 de Febrero de 2015
Modificaciones estatutarias. 15. Acciones/Participaciones.- Modificaci贸n del art铆culo 15潞 de los Estatutos sociales.. Datosregistrales. T 27069 , F 147, S 8, H M 367466, I/A 169 (12.02.15).

11 de Febrero de 2015
Otros conceptos: Aprobaci贸n del Reglamento de la Junta. Datos registrales. T 27069 , F 131, S 8, H M 367466, I/A 164 (30.01.15).

Otros conceptos: Aprobaci贸n Reglamento del Consejo. Datos registrales. T 27069 , F 137, S 8, H M 367466, I/A 165 (30.01.15).

Nombramientos. Con.Ind.Coor: SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ ANGEL. Datos registrales. T 27069 , F 145, S 8, H M 367466,I/A 166 (30.01.15).

Nombramientos. SecComAudit: FALCON RAVELO JUAN FRANCISCO. Mbro.Cte.NyR: GOMEZ-NAVARRO NAVARRETEJAVIER;MOURE BOURIO FRANCISCO;GONZALEZ MORCILLO SERAFIN.Pdte.Cte.NyR: GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE JAVIER.Secr.Com.Ret: FALCON RAVELO JUAN FRANCISCO. MiemComAuCnt: SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ ANGEL;INVERSIONESCORPORATIVAS DIGITALES SL;HERNANDEZ MANCHA ANTONIO;ROS MAORAD JOSE LUIS. PresComAuCnt: SERRANOMARTINEZ-ESTELLEZ ANGEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Comisi贸n deAuditor铆a y Control. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Comit茅 de Nombramientos y Retribuciones.Datos registrales. T 27069 , F 146, S 8, H M 367466, I/A 167 (30.01.15).

10 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;LWOFF IVANISSEVICH ALEJANDRA. Datos registrales. T27069 , F 147, S 8, H M 367466, I/A 168 ( 2.02.15).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PORTELA ALVAREZ ANTONIO. Consejero: ROS MAORAD JOSE LUIS;INVERSIONESCORPORATIVAS SA;DELSO HERAS LUIS;GONZALEZ MORCILLO SERAFIN;SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZANGEL;CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL;CARTERA PERSEIDAS SL;PORTELA ALVAREZ ANTONIO;GOMEZ NAVARRONAVARRETE JAVIER;SERCAPGU SL;HISCAN PATRIMONIO SA;INVERSIONES CORPORATIVAS DIGITALES SL;MOURE BOURIOFRANCISCO;HERNANDEZ MANCHA ANTONIO. Presidente: DELSO HERAS LUIS ANTONIO. Vicepresid.: CONSTRUCTIONINVESTMENTS SARL. Nombramientos. Consj.Domini: CARTERA PERSEIDAS SL. Con.Ind.: GOMEZ NAVARRO NAVARRETEJAVIER;GONZALEZ MORCILLO SERAFIN;HERNANDEZ MANCHA ANTONIO. Consj.Domini: HISCAN PATRIMONIOSA;INVERSIONES CORPORATIVAS DIGITALES SL;INVERSIONES CORPORATIVAS SA. Con.Ind.: MOURE BOURIO

05 de Febrero de 2015
Nombramientos. Con.Delegado: PORTELA ALVAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 27069 , F 131, S 8, H M 367466, I/A 163(28.01.15).

03 de Febrero de 2015
Nombramientos. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 342.323.022,80 Euros. Desembolsado: 342.323.022,80 Euros. Resultante Suscrito: 360.340.024,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 360.340.024,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 267.552.467,82 Euros. Resultante Suscrito:92.787.556,18 Euros. Modificaciones estatutarias. Aprobaci贸n de nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales.. Otrosconceptos: MODIFICACION REPRESENTACION ACCIONES CLASE A Y B: TRANSFORMACION EN ANOTACIONES ENCUENTA. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.isoluxcorsan.com. Datos registrales. T 27069 ,F 121, S 8, H M 367466, I/A 161 (27.01.15).

13 de Octubre de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: BARRIERO NOGALEDO ENRIQUE;LORENZO FERNANDEZ RAFAEL CARLOS;GOMEZ MARTINEZCRISTIAN;REINA PINTO JUAN CARLOS. Apo.Sol.: BARRIERO NOGALEDO ENRIQUE. Apo.Manc.: BARRIERO NOGALEDOENRIQUE;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;SERRANO SANCHEZ FERNANDO;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZBEGO脩A;MENDOZA BUENDIA CARLOS. Datos registrales. T 27069 , F 119, S 8, H M 367466, I/A 160 ( 6.10.14).

20 de Agosto de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 27069 , F 119, S 8, H M 367466, I/A 159 (11.08.14).

29 de Abril de 2014
Reelecciones. Consejero: HERNANDEZ MANCHA ANTONIO. Datos registrales. T 27069 , F 118, S 8, H M 367466, I/A 158(21.04.14).

22 de Abril de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ TELLO ANTONIO;SERRANO SANCHEZ FERNANDO. Apo.Sol.: SERRANO SANCHEZFERNANDO. Apo.Manc.: CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 27069 , F 117, S 8, H M 367466, I/A 156 (10.04.14).

Nombramientos. Apoderado: REINA PINTO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 27069 , F 117, S 8, H M 367466, I/A 157(10.04.14).

06 de Marzo de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BENITO RICHARDS DAVID. Apo.Manc.: LORENZO FERNANDEZ RAFAEL CARLOS;DELSORAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;MENDOZA BUENDIA CARLOS;REINA PINTO JUANCARLOS;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;SERRANO SANCHEZ FERNANDO;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZBEGO脩A. Datos registrales. T 27069 , F 112, S 8, H M 367466, I/A 153 (26.02.14).

Nombramientos. Apo.Manc.: REINA PINTO JUAN CARLOS;LORENZO FERNANDEZ RAFAEL CARLOS;DELSO RAMIREZ DELMOLINO ALVARO;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;MENDOZA BUENDIA CARLOS. Apoderado: REINA PINTO JUAN CARLOS.Apo.Manc.: REINA PINTO JUAN CARLOS;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;SERRANO SANCHEZ FERNANDO;SANCHEZ TELLOANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 27069 , F 114, S 8, H M 367466, I/A 154 (27.02.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ TELLO ANTONIO. Apo.Manc.: SERRANO SANCHEZ FERNANDO;GARCIA MATEOSMANUEL JOSE;CRUZ CRUZ BEGO脩A;SERRANO SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 27069 , F 116, S 8, H M 367466,I/A 155 (27.02.14).

24 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: LORENZO FERNANDEZ RAFAEL CARLOS;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;GOMEZ MARTINEZCRISTIAN;REINA PINTO JUAN CARLOS;MENDOZA BUENDIA CARLOS. Apo.Man.Soli: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO.Apo.Manc.: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A;SERRANO SANCHEZFERNANDO. Datos registrales. T 27069 , F 110, S 8, H M 367466, I/A 152 (14.02.14).

20 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Representan: ALEMANY MAS SALVADOR. Nombramientos. Representan: CASAS BEDOS JORDI. Datosregistrales. T 27069 , F 110, S 8, H M 367466, I/A 151 (12.02.14).

23 de Septiembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: MORENO ALVAREZ LUIS;MORENO GRANDE FRANCISCO. Apo.Manc.: SAR GOMEZ EUGENIORAMON. Apo.Man.Soli: BERENGUEL VAZQUEZ JUAN;BARREIRO ARTEIJO EDUARDO;BARCENAS GUTIERREZ MANUELIGNACIO. Apoderado: MARTINEZ ABELAIRAS ALBERTO. Apo.Man.Soli: GRACIA CEBOLLADA ANTONIO;RIERA TABOAS JAVIER.Apo.Manc.: MESEGUER VELASCO JOSE LUIS. Apoderado: SARACHO ARNAIZ ISABEL;VILLACA脩AS BEADES ANA;SAR GOMEZEUGENIO RAMON;VILLACA脩AS BEADES ANA. Apo.Manc.: VILLACA脩AS BEADES ANA;VILLACA脩AS BEADES ANA. Datosregistrales. T 27069 , F 109, S 8, H M 367466, I/A 149 ( 9.09.13).

Nombramientos. Apoderado: VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A;PEREZQUESADA JUAN MANUEL;ROPERO GARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 27069 , F 110, S 8, H M 367466, I/A 150 (9.09.13).

04 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: LORENZO FERNANDEZ RAFAEL CARLOS;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;MARTINEZBORRALLO ANTONIO;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;REINA PINTO JUAN CARLOS;MENDOZA BUENDIA CARLOS;LORENZOFERNANDEZ RAFAEL CARLOS;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLOANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 27069 , F 107, S 8, H M 367466, I/A 148 (27.08.13).

23 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apoderado: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;LORENZO FERNANDEZ RAFAEL CARLOS;MARTINEZBORRALLO ANTONIO;REINA PINTO JUAN CARLOS;MENDOZA BUENDIA CARLOS;DELSO RAMIREZ DEL MOLINOALVARO;DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;VALENZUELA CONTRERASCOSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 27069 , F 105, S 8, H M 367466, I/A 147(12.08.13).

13 de Agosto de 2013
Nombramientos. Con.Delegado: PORTELA ALVAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 27069 , F 104, S 8, H M 367466, I/A 146 (5.08.13).

01 de Agosto de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 27069 , F 104, S 8, H M 367466, I/A 145 (24.07.13).

22 de Julio de 2013
Reelecciones. Consejero: MOURE BOURIO FRANCISCO. Datos registrales. T 27069 , F 104, S 8, H M 367466, I/A 144 (11.07.13).

26 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PORTELA ALVAREZ ANTONIO;GARCIA MARTIN FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T27069 , F 104, S 8, H M 367466, I/A 142 (18.06.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MARTIN FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 27069 , F 104, S 8, H M 367466, I/A 143(18.06.13).

04 de Junio de 2013
Nombramientos. Apoderado: PORTELA ALVAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 27069 , F 102, S 8, H M 367466, I/A 141(28.05.13).

16 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: DE PEDRO DELGADO LUIS CARLOS. Datos registrales. T 27069 , F 101, S 8, H M 367466, I/A 139 (7.05.13).

Revocaciones. Apoderado: PASTRANA PASTRANA OCTAVIO FRANCISCO;PASTRANA PASTRANA OCTAVIOFRANCISCO;PASTRANA PASTRANA OCTAVIO FRANCISCO. Datos registrales. T 27069 , F 101, S 8, H M 367466, I/A 140 (7.05.13).

14 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: SANCHEZ ALVAREZ VICENTE. Nombramientos. Representan: MARTINEZ MARQUEZLORENZO JOSE. Datos registrales. T 27069 , F 101, S 8, H M 367466, I/A 138 ( 6.05.13).

06 de Marzo de 2013
Nombramientos. Apoderado: MOYANO RUBIO FLORENCIO. Datos registrales. T 27069 , F 100, S 8, H M 367466, I/A 136(26.02.13).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ANTUNEZ ANTONIO JOSE JESUS. Datos registrales. T 27069 , F 100, S 8, H M 367466, I/A 137(26.02.13).

08 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ PEREZ ROBERTO. Datos registrales. T 27069 , F 100, S 8, H M 367466, I/A 135 (31.01.13).

07 de Febrero de 2013
Nombramientos. Con.Delegado: GARCIA MARTIN FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 27069 , F 99, S 8, H M 367466, I/A134 (30.01.13).

06 de Febrero de 2013
Nombramientos. Consejero: GARCIA MARTIN FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 27069 , F 99, S 8, H M 367466, I/A 133(29.01.13).

01 de Febrero de 2013
Otros conceptos: RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 131&. Datos registrales. T 27069 , F 99, S 8, H M 367466, I/A 132

22 de Enero de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 553.761,40 Euros. Desembolsado: 553.761,40 Euros. Resultante Suscrito: 18.017.001,20 Euros.Resultante Desembolsado: 18.017.001,20 Euros. Datos registrales. T 27069 , F 98, S 8, H M 367466, I/A 131 (15.01.13).

10 de Enero de 2013
Nombramientos. Apoderado: TEJERIZO SANCHEZ ANA;SERRANO SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 27069 , F 98, S8, H M 367466, I/A 130 ( 2.01.13).

27 de Diciembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: EL MONTE DE PIEDAD CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEV;GRUPO CORPORATIVOEMPRESARIAL DE LA CAJA DE AHORRO. Representan: LOPEZ MILAGRO EDUARDO;PULIDO GUTIERREZ ANTONIO.Nombramientos. Representan: ALEMANY MAS SALVADOR;MERCADER MIRO JORGE;BELLAVISTA AULADELL FRANCESC.Consejero: SERCAPGU SL;HISCAN PATRIMONIO SA;INVERSIONES CORPORATIVAS DIGITALES SL. Datos registrales. T 27069, F 97, S 8, H M 367466, I/A 129 (18.12.12).

03 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ SANZ MARIA. Datos registrales. T 27069 , F 96, S 8, H M 367466, I/A 128 (24.09.12).

12 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: SESMERO LILLO SESUS. Datos registrales. T 27069 , F 96, S 8, H M 367466, I/A 127 (31.08.12).

27 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ BORALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTA ALFONSOMIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO. Apo.Man.Soli: RODERA TOBAL ANA PALOMA. Apo.Manc.: GOMEZ MARTINEZCRISTIAN;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;VIA OZALLA OSCAR;VALERA ULLASTRES SANTIAGO. Datos registrales. T 27069, F 93, S 8, H M 367466, I/A 125 (14.08.12).

Nombramientos. Apo.Sol.: STEMBERT SEGURA JUAN;ATIENZA LA ORDEN JORGE;JURISTO CONTRERAS BRUNO. Datosregistrales. T 27069 , F 95, S 8, H M 367466, I/A 126 (14.08.12).

10 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 27069 , F 93, S 8, H M 367466, I/A 124 ( 1.08.12).

09 de Agosto de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RIBELLES CALDERON ANTONIO. Datos registrales. T 27069 , F 93, S 8, H M 367466, I/A 123(31.07.12).

06 de Julio de 2012
Revocaciones. Apoderado: CABALLERO FERNANDEZ FERNANDO;SENDARRUBIAS REDONDO JOSE MARIA;CABALLEROFERNANDEZ FERNANDO. Datos registrales. T 27069 , F 93, S 8, H M 367466, I/A 122 (26.06.12).

26 de Junio de 2012
Revocaciones. Apoderado: GRACIA CEBOLLADA ANTONIO. Apo.Manc.: GRACIA CEBOLLADA ANTONIO. Datos registrales. T27069 , F 92, S 8, H M 367466, I/A 121 (14.06.12).

26 de Abril de 2012
Revocaciones. Apoderado: MESTRE MORALES-ALBO JOSE-DEMETRIO;MESTRE MORALES ALBO JOSE DEMETRIO.Apo.Manc.: MESTRE MORALES-ALBO JOSE-DEMETRIO. Datos registrales. T 27069 , F 92, S 8, H M 367466, I/A 120 (16.04.12).

08 de Marzo de 2012
Revocaciones. Apoderado: SALMERON UNTURBE JESUS;SALMERON UNTURBE JESUS;SALMERON UNTURBEJESUS;SALMERON UNTURBE JESUS. Datos registrales. T 27069 , F 92, S 8, H M 367466, I/A 119 (27.02.12).

05 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apoderado: MARTIN CASTELLO FELIX. Datos registrales. T 27069 , F 92, S 8, H M 367466, I/A 118 (22.02.12).

09 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Representan: ODERIZ SAN MARTIN JUAN. Nombramientos. Representan: LOPEZ MILAGRO EDUARDO.Datos registrales. T 27069 , F 92, S 8, H M 367466, I/A 117 (28.01.12).

17 de Enero de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;GRACIACEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES-ALBO JOSE-DEMETRIO;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;VIA OZALLAOSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Apo.Sol.: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Datos registrales. T 27069 , F 88, S 8, H M367466, I/A 116 ( 4.01.12).

29 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTIN MORALES-CASTILLA FRANCISCO;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOSMANUEL JOSE;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL.Datos registrales. T 27069 , F 88, S 8, H M 367466, I/A 115 (16.11.11).

16 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: PASTRANA PASTRANA OCTAVIO FRANCISCO;OJEDA RUIZ DE LUNA JOSE MARIA;FERRIO DIAZVICENTE;GAMO LASTRA EMILIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;VALENZUELACONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 27069 , F 87, S 8, H M 367466, I/A114 ( 2.11.11).

26 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apoderado: SOTO SANCHEZ MERCEDES. Datos registrales. T 27069 , F 87, S 8, H M 367466, I/A 113(13.10.11).

29 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Consejero: CARTERA PERSEIDAS SL;PORTELA ALVAREZ ANTONIO;GOMEZ NAVARRO NAVARRETEJAVIER;GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE LA CAJA DE AHORRO. Datos registrales. T 27069 , F 86, S 8, H M 367466,I/A 111 (16.09.11).

Reelecciones. Con.Delegado: PORTELA ALVAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 27069 , F 87, S 8, H M 367466, I/A 112(16.09.11).

28 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Representan: HERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Representan: DE TORRES ZABALAJOSE MARIA. Datos registrales. T 27069 , F 86, S 8, H M 367466, I/A 110 (15.09.11).

22 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 27069 , F 86, S 8, H M 367466, I/A 109 (12.09.11).

15 de Junio de 2011
Nombramientos. Apoderado: MARTIN CASTELLO FELIX. Datos registrales. T 27069 , F 84, S 8, H M 367466, I/A 107 ( 6.06.11).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MARTIN JOSE JESUS. Datos registrales. T 27069 , F 84, S 8, H M 367466, I/A 108 (6.06.11).

23 de Mayo de 2011
Ceses/Dimisiones. Representan: AVILA GONZALEZ JUAN JOSE. Nombramientos. Representan: SANCHEZ ALVAREZ VICENTE.Datos registrales. T 27069 , F 84, S 8, H M 367466, I/A 106 (12.05.11).

24 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SANZ MARIA. Datos registrales. T 27069 , F 84, S 8, H M 367466, I/A 105 (14.02.11).

23 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apoderado: SIERRA GONZALEZ JESUS;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE.Datos registrales. T 27069 , F 82, S 8, H M 367466, I/A 103 (10.02.11).

Nombramientos. Apoderado: GARRIDO DE LAS HERAS JOSE;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUELJOSE;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA. Datosregistrales. T 27069 , F 83, S 8, H M 367466, I/A 104 (10.02.11).

08 de Febrero de 2011
Otros conceptos: Subsanaci贸n de la escritura que origin贸 la inscripci贸n 99&. Datos registrales. T 27069 , F 81, S 8, H M 367466,I/A 102 (28.01.11).

23 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: DE LOS MOZOS PASCUAL NORBERTO. Datos registrales. T 27069 , F 81, S 8, H M 367466, I/A101 (13.12.10).

17 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ MU脩OZ ANTONIO JESUS;SAGASTIZABAL CARDELUS ALFONSO MARIA;MOYANORUBIO FLORENCIO;MARTINEZ ZURITA JAVIER;SANCHEZ ROJAS JUAN DE DIOS;CALVO REY MANUEL. Datos registrales. T27069 , F 80, S 8, H M 367466, I/A 100 ( 4.11.10).

05 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACA脩AS BEADES ANA;DE EGA脩A HUERTAALFONSO MIGUEL;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE;SALMERON UNTURBEJESUS;CABALLERO FERNANDEZ FERNANDO;GRACIA CEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES ALBO JOSEDEMETRIO;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER;SAR GOMEZ EUGENIO RAMON;MARSAL MOYANO RICARDO;VIA OZALLAOSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Datos registrales. T 27069 , F 79, S 8, H M 367466, I/A 99 (26.10.10).

21 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;MARTINEZBORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;SALMERON UNTURBE JESUS. Datos registrales. T 27069 , F 77, S 8, HM 367466, I/A 98 (11.10.10).

28 de Septiembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ NU脩EZ ANTONIO;SERRATOSA GONZALEZ GROS ANDRES;PAREDES ZAVALACARLOS;VILCHES MILLAN FRANCISCO;RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER;GARGALLO VAL JUAN RAMON;QUINTANATABEADA JOSE MARIA;MARTINEZ LOPEZ JOSE LUIS. Apo.Manc.: SAN JOSE VAQUERO GERMAN;CHENAB COUTYA NAGI.Apo.Man.Soli: ALONSO MARTINEZ ANTONIO. Apoderado: VARGAS TABERNERO ENRIQUE JOSE;VARGAS TABERNEROENRIQUE JOSE;GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ ANTONIO JUAN. Apo.Man.Soli: VARGAS TABERNERO ENRIQUE JOSE.Apo.Manc.: VARGAS TABERNERO ENRIQUE JOSE. Datos registrales. T 27069 , F 77, S 8, H M 367466, I/A 97 (17.09.10).

21 de Septiembre de 2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 27069 , F 77, S 8, H M 367466, I/A 96 (24.08.10).

13 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: SARACHO ARNAIZ ISABEL. Datos registrales. T 27069 , F 76, S 8, H M 367466, I/A 95 ( 1.09.10).

06 de Septiembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: AVILA GONZALEZ JUAN JOSE. Nombramientos. Representan: AVILA GONZALEZ JUAN JOSE.Consejero: CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACION SA. Reelecciones. Consejero: DELSO HERAS LUIS;GONZALEZMORCILLO SERAFIN;SERRANO MARTINEZ ESTELLEZ ANGEL. Presidente: DELSO HERAS LUIS ANTONIO. Consejero:CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL;EL MONTE DE PIEDAD CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVVicepresid.:CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL. Datos registrales. T 27069 , F 75, S 8, H M 367466, I/A 94 (25.08.10).

27 de Julio de 2010
Nombramientos. Apoderado: VALGA脩ON VILLANUEVA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 27069 , F 75, S 8, H M 367466, I/A93 (15.07.10).

23 de Junio de 2010
Nombramientos. Consejero: ROS MAORAD JOSE LUIS. Datos registrales. T 27069 , F 75, S 8, H M 367466, I/A 92 (11.06.10).

20 de Mayo de 2010
Nombramientos. Apoderado: VIA OZALLA OSCAR. Datos registrales. T 27069 , F 74, S 8, H M 367466, I/A 91 ( 6.05.10).

28 de Abril de 2010
Revocaciones. Apoderado: REGIFO ABBAD ALVARO. Datos registrales. T 27069 , F 74, S 8, H M 367466, I/A 90 (15.04.10).

24 de Marzo de 2010
Nombramientos. Apoderado: SAGASTIZABAL CARDELUS ALFONSO MARIA;HERNANDEZ MU脩OZ ANTONIO JESUS. Datosregistrales. T 27069 , F 73, S 8, H M 367466, I/A 89 (12.03.10).

22 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apoderado: PIJOAN MARIN ESTEBAN. Apo.Man.Soli: MAZA BURGOS JAVIER;TOVAR ROMERO CARLOS JOSE.Apo.Manc.: TEJEDOR BENEDICTO LUIS. Apo.Sol.: TEJEDOR BENEDICTO LUIS. Datos registrales. T 27069 , F 73, S 8, H M367466, I/A 88 (10.03.10).

09 de Marzo de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PASTRANA PASTRANA OCTAVIO FRANCISCO. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLOANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE. Apo.Man.Soli: CHACON GIACOMAN RODOLFO GUILLERMO;GAMO LASTRAEMILIO. Apoderado: OLTRA LAGUILLO FERNANDO. Datos registrales. T 27069 , F 70, S 8, H M 367466, I/A 87 (25.02.10).

26 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apoderado: MESEGUER VELASCO JOSE LUIS;MESEGUER VELASCO JOSE LUIS;MESEGUER VELASCO JOSELUIS Datos registrales. T 27069 , F 70, S 8, H M 367466, I/A 86 (11.02.10).

29 de Enero de 2010
Nombramientos. Apoderado: CASADO MARCOS ESTHER. Datos registrales. T 27069 , F 70, S 8, H M 367466, I/A 85 (18.01.10).

26 de Enero de 2010
Nombramientos. Apoderado: MARSAL MOYANO RICARDO;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE.Datos registrales. T 23256 , F 139, S 8, H M 367466, I/A 84 (15.01.10).

21 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Datos registrales. T 23256 , F135, S 8, H M 367466, I/A 82 ( 9.12.09).

Nombramientos. Apoderado: SALMERON UNTURBE JESUS;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUELJOSE;VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO. Datos registrales. T 23256 , F 137, S 8, H M 367466, I/A83 ( 9.12.09).

11 de Septiembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SANZ JOSE. Datos registrales. T 23256 , F 135, S 8, H M 367466, I/A 81 (24.08.09).

20 de Agosto de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO. Apo.Manc.: MESEGUER VELASCO JOSE LUIS;GARCIAMATEOS MANUEL JOSE;VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO. Datos registrales. T 23256 , F 133, S8, H M 367466, I/A 80 ( 6.08.09).

05 de Agosto de 2009
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 23256 , F 133, S 8, H M 367466, I/A 79 (27.07.09).

22 de Julio de 2009
Nombramientos. Apoderado: PASTRANA PASTRANA OCTAVIO FRANCISCO. Datos registrales. T 23256 , F 132, S 8, H M367466, I/A 78 ( 8.07.09).

20 de Julio de 2009
Nombramientos. Apoderado: PASTRANA PASTRANA OCTAVIO FRANCISCO. Datos registrales. T 23256 , F 131, S 8, H M367466, I/A 77 ( 8.07.09).

09 de Junio de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RIBELLES CALDERON ANTONIO. Apo.Manc.: VALENZUELA CONTRETAS COSME;SANCHEZTELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 23256 , F 131, S 8, H M 367466, I/A 76 (29.05.09).

23 de Abril de 2009
Nombramientos. Apoderado: CHAMINADE BAUTISTA RAUL CARLOS. Datos registrales. T 23256 , F 130, S 8, H M 367466, I/A74 (13.04.09).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GOMEZ MARIO. Datos registrales. T 23256 , F 131, S 8, H M 367466, I/A 75 (13.04.09).

16 de Febrero de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ NU脩EZ ANTONIO. Datos registrales. T 23256 , F 130, S 8, H M 367466, I/A 73 ( 5.02.09).

26 de Enero de 2009
Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ MANCHA ANTONIO. Datos registrales. T 23256 , F 129, S 8, H M 367466, I/A 72(15.01.09).

21 de Enero de 2009
Revocaciones. Apoderado: CAMPO BUETAS FRANCISCO;ALAIZ FERNANDEZ ENRIQUE. Apo.Man.Soli: POCH PAEZ ANTONIO.Apoderado: GARCIA MARCO JUAN. Datos registrales. T 23256 , F 129, S 8, H M 367466, I/A 71 ( 9.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n