Actos BORME de Grupo Montmesa Sl
18 de Noviembre de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 510,86 Euros. Resultante Suscrito: 84.249,88 Euros. Datos registrales. T 660 , F 148, S8, H HU 5463, I/A 9 ( 8.11.19).
07 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: BORDERIAS LOPEZ EULOGIO;SANMARTIN CAMPO ERNESTO. Presidente: SANMARTIN CAMPOERNESTO. Consejero: VITALLA BERNUES MARIANO. Secretario: OMISTE MARTINEZ FERNANDO. Revocaciones. Apo.Manc.:SANMARTIN CAMPO ERNESTO;OMISTE MARTINEZ FERNANDO;VITALLA BERNUES MARIANO;SARASA SANMARTIN CARLOS.Nombramientos. Presidente: OMISTE MARTINEZ FERNANDO. Consejero: CASTAN GRASA VICTOR-JOSE;ARTIEDA ASOGUILLERMO. Secretario: SARASA SANMARTIN CARLOS. Datos registrales. T 431, L 259, F 225, S 8, H HU 5463, I/A 7 (27.09.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: OMISTE MARTINEZ FERNANDO;SARASA SANMARTIN CARLOS;SANMARTIN REULAERNESTO;CASTAN GRASA VICTOR-JOSE;ARTIEDA ASO GUILLERMO. Datos registrales. T 431, L 259, F 225, S 8, H HU 5463,I/A 8 (27.09.19).
31 de Julio de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 48,08 Euros. Resultante Suscrito: 84.760,74 Euros. Datos registrales. T 431, L 259, F225, S 8, H HU 5463, I/A 6 (24.07.13).
22 de Junio de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 10.175,13 Euros. Resultante Suscrito: 84.808,82 Euros. Datos registrales. T 431, L 259, F224, S 8, H HU 5463, I/A 5 (10.06.09).