Buscador CIF Logo

Actos BORME Grupo Nicolas Mercader Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Grupo Nicolas Mercader Sl

Actos BORME Grupo Nicolas Mercader Sl - B73535056

Tenemos registrados 33 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Grupo Nicolas Mercader Sl con CIF B73535056

馃敊 Perfil de Grupo Nicolas Mercader Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Grupo Nicolas Mercader Sl

29 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SLP. Nombramientos. Auditor: CROWE ACR SLP. Datos registrales. T3396 , F 140, S 8, H MU 65766, I/A 37 (21.12.22).

12 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN BERNAL ROLDAN. Cons.Del.Man: PALOMA NICOLAS MERCADER;MARIA LUZ NICOLASMERCADER;MARIA-GLORIA NICOLAS MERCADER Nombramientos. Consejero: CINTA FERNANDEZ GALLARDO. Cons.Del.Man:MARIA LUZ NICOLAS MERCADER;MARIA-GLORIA NICOLAS MERCADER;PALOMA NICOLAS MERCADER;CINTA FERNANDEZGALLARDO. Datos registrales. T 3396 , F 139, S 8, H MU 65766, I/A 36 ( 5.08.22).

04 de Enero de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: CINTA FERNANDEZ GALLARDO. Nombramientos. Consejero: JUAN BERNAL ROLDAN. Otrosconceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 9.1.D) PUNTOS 3 Y 4 ASI COMO EL 9.5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 3396 , F 139, S 8, H MU 65766, I/A 35 (28.12.21).

05 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SLP. Datos registrales. T 3396 , F 139, S 8, H MU 65766, I/A 34 (29.10.21).

27 de Octubre de 2021
Nombramientos. Consejero: CINTA FERNANDEZ GALLARDO. Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 9 DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3396 , F 138, S 8, H MU 65766, I/A 33 (20.10.21).

20 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: JUAN ANTONIO CAMPILLO GONZALEZ. Nombramientos. Apo.Manc.: MARIA LUCRECIA ALVAREZGOMEZ;CRISTINA RUBIO GOMEZ. Datos registrales. T 3396 , F 138, S 8, H MU 65766, I/A 32 (13.09.21).

28 de Junio de 2021
Nombramientos. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SLP. Datos registrales. T 3396 , F 138, S 8, H MU 65766, I/A 31 (21.06.21).

13 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apoderado: MARIA LUCRECIA ALVAREZ GOMEZ. Datos registrales. T 3396 , F 137, S 8, H MU 65766, I/A 30 (6.05.21).

06 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUSTA MERCADER CANABAL. Presidente: JUSTA MERCADER CANABAL. Consejero: MANUELNICOLAS MERCADER. Secretario: MARIA LUZ NICOLAS MERCADER. Cons.Del.Man: MANUEL NICOLAS MERCADER.Nombramientos. Presidente: MARIA LUZ NICOLAS MERCADER. SecreNoConsj: MARIA LUCRECIA ALVAREZ GOMEZ. Datosregistrales. T 3396 , F 137, S 8, H MU 65766, I/A 29 (25.03.21).

11 de Febrero de 2020
Reelecciones. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SLP. Datos registrales. T 3396 , F 137, S 8, H MU 65766, I/A 28 ( 4.02.20).

21 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: MARIA LUZ NICOLAS MERCADER;MANUEL NICOLAS MERCADER. Nombramientos.Cons.Del.Man: MARIA LUZ NICOLAS MERCADER;MARIA-GLORIA NICOLAS MERCADER;PALOMA NICOLASMERCADER;MANUEL NICOLAS MERCADER. Datos registrales. T 3396 , F 137, S 8, H MU 65766, I/A 27 (15.11.19).

23 de Agosto de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.509.877,55 Euros. Resultante Suscrito: 47.707.891,68 Euros. Cambio de objeto social. a)Lacompra, suscripci贸n, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales y extranjeros, con la finalidad de dirigir, administrar y gestionardichas participaciones. b) Dirigir y gestionar la participaci贸n de la sociedad en el capital de otras entidades mediante la correspondienteorganizaci贸n de. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TORREVALLE AGRICOLA SL. Datos registrales. T 3030 , F 73, S8, H MU 65766, I/A 26 (14.08.19).

05 de Abril de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.203.935,79 Euros. Resultante Suscrito: 48.817.762,21 Euros. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 4.683.993,44 Euros. Resultante Suscrito: 44.133.768,77 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n:2.935.754,64 Euros. Resultante Suscrito: 41.198.014,13 Euros. Datos registrales. T 3030 , F 72, S 8, H MU 65766, I/A 25 (28.03.19).

21 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SLP. Datos registrales. T 3030 , F 72, S 8, H MU 65766, I/A 24 (14.01.19).

16 de Julio de 2018
Nombramientos. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SLP. Datos registrales. T 3030 , F 72, S 8, H MU 65766, I/A 23 ( 5.07.18).

25 de Junio de 2018
Cambio de domicilio social. AVDA TENIENTE MONTESINOS 9 - ESPINARDO (MURCIA). Datos registrales. T 3030 , F 71, S 8, HMU 65766, I/A 20 (18.06.18).

Revocaciones. Apo.Manc.: VICENTA LUNA RODRIGUEZ;CONRADO PRIOR GARCIA;JOSE CASANOVA TOVAR;PASCUALPALAZON PALAZON;MARIA-GLORIA NICOLAS MERCADER;MARIANO CONCEPCION JIMENEZ CANTERO;CONRADO PRIORGARCIA;JOSE CASANOVA TOVAR;PASCUAL PALAZON PALAZON;MARIA-GLORIA NICOLAS MERCADER. Datos registrales. T3030 , F 72, S 8, H MU 65766, I/A 21 (18.06.18).

Nombramientos. Apoderado: JUAN ANTONIO CAMPILLO GONZALEZ. Datos registrales. T 3030 , F 72, S 8, H MU 65766, I/A 22(18.06.18).

23 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SLP. Datos registrales. T 3030 , F 71, S 8, H MU 65766, I/A 19 (16.11.17).

07 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUSTA MERCADER CANAVAL;GLORIA MARIA NICOLAS MERCADER;PALOMA NICOLASMERCADER;MANUEL NICOLAS MERCADER;MARIA LUZ NICOLAS MERCADER. Secretario: MARIA LUZ NICOLAS MERCADER.Cons.Del.Man: JUSTA MERCADER CANAVAL;MARIA LUZ NICOLAS MERCADER;GLORIA MARIA NICOLASMERCADER.Presidente: GLORIA MARIA NICOLAS MERCADER. Nombramientos. Consejero: JUSTA MERCADERCANABAL;MARIA-GLORIA NICOLAS MERCADER;MARIA LUZ NICOLAS MERCADER;PALOMA NICOLAS MERCADER;MANUELNICOLAS MERCADER. Presidente: JUSTA MERCADER CANABAL. Secretario: MARIA LUZ NICOLAS MERCADER. Cons.Del.Man:MANUEL NICOLAS MERCADER;MARIA LUZ NICOLAS MERCADER. Datos registrales. T 3030 , F 71, S 8, H MU 65766, I/A 18(31.07.15).

16 de Julio de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 33.584.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 51.021.698,00 Euros. Escisi贸n parcial.Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: CANO NICOLAS M M SL. GRUPO BINZA SL. GRUPO NICOLAS MOTOR SL. GRUPO NMPREMIUM SL. Datos registrales. T 3030 , F 71, S 8, H MU 65766, I/A 17 ( 8.07.15).

03 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Presidente: JUSTA MERCADER CANAVAL. Nombramientos. Presidente: GLORIA MARIA NICOLASMERCADER. Datos registrales. T 3030 , F 70, S 8, H MU 65766, I/A 16 (26.09.14).

12 de Septiembre de 2014
Cambio de objeto social. El desarrollo, como sociedad de intermediaci贸n, respecto de aquellas actividades que sean susceptibles dedesarrollar de forma profesional: La direccion y gestion por cuenta propia de participaciones en entidades de todo tipo, tengan o nopersonalidad juridica, mediante la correspondiente organizaci. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ISLARENA SL.MANUEL NICOLAS E HIJOS SL. MANUEL NICOLAS GARCIA SL. NIMERCA SL. Datos registrales. T 3030 , F 70, S 8, H MU 65766,I/A 15 ( 5.09.14).

11 de Abril de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.687.136,00 Euros. Resultante Suscrito: 84.605.698,00 Euros. Datos registrales. T 2534 , F 141, S8, H MU 65766, I/A 14 ( 4.04.14).

23 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: MARIANO CONCEPCION JIMENEZ CANTERO;CONRADO PRIOR GARCIA;JOSE CASANOVATOVAR;PASCUAL PALAZON PALAZON;MARIA-GLORIA NICOLAS MERCADER. Datos registrales. T 2534 , F 141, S 8, H MU65766, I/A 13 (16.08.13).

26 de Junio de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: PEDRO VALERA RUIZ. Datos registrales. T 2534 , F 140, S 8, H MU 65766, I/A 12 (20.06.13).

12 de Julio de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: PEDRO VALERA RUIZ;VICENTA LUNA RODRIGUEZ;CONRADO PRIOR GARCIA;JOSE CASANOVATOVAR;PASCUAL PALAZON PALAZON;MARIA-GLORIA NICOLAS MERCADER. Datos registrales. T 2534 , F 140, S 8, H MU65766, I/A 11 ( 4.07.12).

15 de Junio de 2012
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: MARIA LUZ NICOLAS MERCADER;GLORIA MARIA NICOLAS MERCADER. Nombramientos.Cons.Del.Man: JUSTA MERCADER CANAVAL;MARIA LUZ NICOLAS MERCADER;GLORIA MARIA NICOLAS MERCADER. Datosregistrales. T 2534 , F 140, S 8, H MU 65766, I/A 10 ( 6.06.12).

26 de Enero de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.728.062,00 Euros. Resultante Suscrito: 78.918.562,00 Euros. Datos registrales. T 2534 , F 140, S8, H MU 65766, I/A 9 (17.01.12).

19 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: MARIA LUZ NICOLAS MERCADER;MANUEL NICOLAS MERCADER. Nombramientos.Cons.Del.Man: MARIA LUZ NICOLAS MERCADER;GLORIA MARIA NICOLAS MERCADER. Datos registrales. T 2534 , F 140, S 8,H MU 65766, I/A 8 ( 8.04.11).

31 de Enero de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.458.168,00 Euros. Resultante Suscrito: 76.190.500,00 Euros. Datos registrales. T 2534 , F 139,S 8, H MU 65766, I/A 7 (20.01.11).

14 de Junio de 2010
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MANUEL NICOLAS MERCADER. Nombramientos. Cons.Del.Man: MARIA LUZ NICOLASMERCADER;MANUEL NICOLAS MERCADER. Datos registrales. T 2534 , F 139, S 8, H MU 65766, I/A 6 ( 3.06.10).

21 de Octubre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUSTA MERCADER CANABAL;GLORIA MARIA NICOLAS MERCADER;PALOMA NICOLASMERCADER;MANUEL NICOLAS MERCADER;MARIA LUZ NICOLAS MERCADER;JUAN BERNAL ROLDAN. Presidente: JUSTAMERCADER CANABAL. Con.Delegado: MANUEL NICOLAS MERCADER. SecreNoConsj: RAFAEL CEBRIAN CARRILLO.Nombramientos. Consejero: JUSTA MERCADER CANAVAL;GLORIA MARIA NICOLAS MERCADER;PALOMA NICOLASMERCADER;MANUEL NICOLAS MERCADER;MARIA LUZ NICOLAS MERCADER. Presidente: JUSTA MERCADER CANAVAL.Secretario: MARIA LUZ NICOLAS MERCADER. Con.Delegado: MANUEL NICOLAS MERCADER. Datos registrales. T 2534 , F 139,S 8, H MU 65766, I/A 5 ( 9.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n