Actos BORME de Grupo Pra Sa
25 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: AMAYA GALVAN JOAQUIN ENRIQUE. Datos registrales. T 2265 , F 144, S 8, H CO 1696, I/A 142(12.04.22).
13 de Noviembre de 2019Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 465/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 9/10/2019. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CORDOBA. Juez: MARIA VICTORIAFERNANDEZ MOLINA TIRADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 465/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n9/10/2019. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado.Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CORDOBA. Juez: MARIA VICTORIA FERNANDEZ MOLINATIRADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 465/2019. Fecha de resoluci贸n 9/10/2019. Nombramiento deadministradores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CORDOBA. Juez: MARIA VICTORIA FERNANDEZMOLINA TIRADO. Administrador Concursal. Fecha 9/10/2019, NIF/CIF B14932610. ALFA ASESORES CONCURSALES SLP. Datosregistrales. T 2265 , F 143, S 8, H CO 1696, I/A 141 ( 6.11.19).
14 de Junio de 2018Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 2265 , F 143, S 8, H CO 1696, I/A 140 (7.06.18).
05 de Febrero de 2018Reelecciones. Adm. Unico: ROMERO GONZALEZ JOSE. Datos registrales. T 2265 , F 143, S 8, H CO 1696, I/A 139 (29.01.18).
30 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: AUDIBALANCE SLP. Aud.C.Con.: AUDIBALANCE SLP. Datos registrales. T 2265 , F 142, S 8, H CO1696, I/A 138 (22.01.18).
17 de Abril de 2017Cambio de domicilio social. C/ SAN ALVARO 2 ENTREPLA (CORDOBA). Datos registrales. T 2265 , F 142, S 8, H CO 1696, I/A137 ( 6.04.17).
07 de Febrero de 2017Modificaciones estatutarias. 12.B. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. Datos registrales. T 2265 , F 142, S 8, H CO1696, I/A 136 (31.01.17).
11 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: TIRADO LOPEZ JOSE;TIRADO LOPEZ JOSE;ROMERO GONZALEZ CELEDONIO;ORIZAOLA PAZENRIQUE CARLOS FRANCISCO;FERNANDEZ BERCHEZ CARLOS;MARQUEZ PASTOR ANTONIO;MARQUEZ PASTORANTONIO;FERNANDEZ BERCHEZ CARLOS;FERNANDEZ BERCHEZ CARLOS;TIRADO LOPEZ JOSE;JORDAN CRESPOTEODOSIO ANTONIO;SEPULVEDA SANCHEZ FRANCISCO;SEPULVEDA SANCHEZ FRANCISCO;ROMERO GONZALEZPABLO;ROMERO GONZALEZ PABLO;MORA QUERO MIGUEL ANGEL;MORA QUERO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ MORENORAFAEL;SANCHEZ MORENO RAFAEL;JORDAN CRESPO TEODOSIO ANTONIO;SEPULVEDA SANCHEZ
24 de Octubre de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 76.772.576,95 Euros. Resultante Suscrito: 10.846.909,75 Euros. Datos registrales. T2265 , F 138, S 8, H CO 1696, I/A 133 (17.10.16).
14 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: GADEA RAMOS MARIA LOURDES. Datos registrales. T 2265 , F 139, S 8, H CO 1696, I/A 132 (7.06.16).
03 de Marzo de 2016Fusi贸n por uni贸n. Sociedades que se fusi贸nan: PRASA EJECUCION DE OBRAS SL. OUTSOURCING SEGUROS DE CORDOBANORTE SL. ESPACIO TURISTICO SOSTENIBLE SIERRA DE LA MOTA SL. PRASA CANARIAS SL. BENALUA SUR, SL.ARRENDAMIENTOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS SA. Datos registrales. T 2265 , F 134, S 8, H CO 1696, I/A 131 (25.02.16).
22 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apoderado: CAMPANERO BRETONES MANUEL. Datos registrales. T 2265 , F 134, S 8, H CO 1696, I/A 130(15.12.15).
31 de Marzo de 2015Revocaciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE AUDITORIA SA. Nombramientos. Auditor: ALCALA ZAMORA BARRON LUIS.Aud.Supl.: AGUERA JIMENEZ JUAN. Datos registrales. T 2265 , F 133, S 8, H CO 1696, I/A 129 (25.03.15).
19 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: CANO CABANILLAS RAQUEL. Datos registrales. T 2265 , F 133, S 8, H CO 1696, I/A 128 (13.11.14).
22 de Julio de 2014Revocaciones. Apoderado: GENTIL ALCOBENDAS FRANCISCO;GENTIL ALCOBENDAS FRANCISCO. Datos registrales. T 2265, F 132, S 8, H CO 1696, I/A 127 (16.07.14).
16 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ CARRASCO JULIO. Datos registrales. T 2265 , F 132, S 8, H CO 1696, I/A 126 ( 9.06.14).
12 de Mayo de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 100.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 87.619.486,70 Euros. Datos registrales. T2265 , F 131, S 8, H CO 1696, I/A 125 ( 5.05.14).
06 de Febrero de 2013Nombramientos. Auditor: ESPAUDIT GABINETE AUDITORIA SA. Datos registrales. T 2265 , F 131, S 8, H CO 1696, I/A 124(30.01.13).
15 de Noviembre de 2012Revocaciones. Auditor: AUDIBALANCE SL. Datos registrales. T 2265 , F 131, S 8, H CO 1696, I/A 123 ( 5.11.12).
17 de Febrero de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS;ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMERO GONZALEZJUANA;JORDAN CRESPO TEODOSIO ANTONIO. Datos registrales. T 1549 , F 225, S 8, H CO 1696, I/A 122 ( 8.02.12).
13 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS. Consejero: ROMERO GONZALEZ JUANA;ROMEROGONZALEZ JOSE. Presidente: ROMERO GONZALEZ JOSE. Consejero: ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMERO GONZALEZCELEDONIO;ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS. Cons.Del.Sol: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS;ROMERO GONZALEZJOSE. SecreNoConsj: AMAYA GALVAN JOAQUIN ENRIQUE. Nombramientos. Adm. Unico: ROMERO GONZALEZ JOSE.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. 13.Administraci贸n y Representacion.-. 14. Administraci贸ny Representacion.-. 15. Administraci贸n y Representacion.-. 16. Administraci贸n yRepresentacion.-. 17. Administraci贸ny Representacion.-. 18. Administraci贸n y Representacion.-. 19. Administraci贸n y Representacion.-.Datos registrales. T 1549 , F 224, S 8, H CO 1696, I/A 121 ( 2.02.12).
22 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: AUDIBALANCE SL. Datos registrales. T 1549 , F 224, S 8, H CO 1696, I/A 119 (10.11.11).
30 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CRIADO BLANCO INMACULADA. Nombramientos. SecreNoConsj: AMAYA GALVANJOAQUIN ENRIQUE. Datos registrales. T 1549 , F 223, S 8, H CO 1696, I/A 118 (19.08.11).
22 de Julio de 2011Nombramientos. Apoderado: LEON GALVIN RAFAEL. Datos registrales. T 1549 , F 223, S 8, H CO 1696, I/A 117 (14.07.11).
07 de Julio de 2011Nombramientos. Apoderado: GENTIL ALCOBENDAS FRANCISCO. Datos registrales. T 1549 , F 222, S 8, H CO 1696, I/A 116(28.06.11).
24 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: MU脩OZ FERNANDEZ MARIA JOSE;CASADO PRADO GUILLERMO. Datos registrales. T 1549 , F 221,S 8, H CO 1696, I/A 115 (15.11.10).