Buscador CIF Logo

Actos BORME Grupo Pra Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Grupo Pra Sa

Actos BORME Grupo Pra Sa - A14027635

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Cordoba para Grupo Pra Sa con CIF A14027635

馃敊 Perfil de Grupo Pra Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Cordoba

Actos BORME de Grupo Pra Sa

25 de Abril de 2022
Revocaciones. Apoderado: AMAYA GALVAN JOAQUIN ENRIQUE. Datos registrales. T 2265 , F 144, S 8, H CO 1696, I/A 142(12.04.22).

13 de Noviembre de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 465/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 9/10/2019. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CORDOBA. Juez: MARIA VICTORIAFERNANDEZ MOLINA TIRADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 465/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n9/10/2019. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado.Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CORDOBA. Juez: MARIA VICTORIA FERNANDEZ MOLINATIRADO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 465/2019. Fecha de resoluci贸n 9/10/2019. Nombramiento deadministradores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CORDOBA. Juez: MARIA VICTORIA FERNANDEZMOLINA TIRADO. Administrador Concursal. Fecha 9/10/2019, NIF/CIF B14932610. ALFA ASESORES CONCURSALES SLP. Datosregistrales. T 2265 , F 143, S 8, H CO 1696, I/A 141 ( 6.11.19).

14 de Junio de 2018
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 2265 , F 143, S 8, H CO 1696, I/A 140 (7.06.18).

05 de Febrero de 2018
Reelecciones. Adm. Unico: ROMERO GONZALEZ JOSE. Datos registrales. T 2265 , F 143, S 8, H CO 1696, I/A 139 (29.01.18).

30 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: AUDIBALANCE SLP. Aud.C.Con.: AUDIBALANCE SLP. Datos registrales. T 2265 , F 142, S 8, H CO1696, I/A 138 (22.01.18).

17 de Abril de 2017
Cambio de domicilio social. C/ SAN ALVARO 2 ENTREPLA (CORDOBA). Datos registrales. T 2265 , F 142, S 8, H CO 1696, I/A137 ( 6.04.17).

07 de Febrero de 2017
Modificaciones estatutarias. 12.B. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. Datos registrales. T 2265 , F 142, S 8, H CO1696, I/A 136 (31.01.17).

11 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: TIRADO LOPEZ JOSE;TIRADO LOPEZ JOSE;ROMERO GONZALEZ CELEDONIO;ORIZAOLA PAZENRIQUE CARLOS FRANCISCO;FERNANDEZ BERCHEZ CARLOS;MARQUEZ PASTOR ANTONIO;MARQUEZ PASTORANTONIO;FERNANDEZ BERCHEZ CARLOS;FERNANDEZ BERCHEZ CARLOS;TIRADO LOPEZ JOSE;JORDAN CRESPOTEODOSIO ANTONIO;SEPULVEDA SANCHEZ FRANCISCO;SEPULVEDA SANCHEZ FRANCISCO;ROMERO GONZALEZPABLO;ROMERO GONZALEZ PABLO;MORA QUERO MIGUEL ANGEL;MORA QUERO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ MORENORAFAEL;SANCHEZ MORENO RAFAEL;JORDAN CRESPO TEODOSIO ANTONIO;SEPULVEDA SANCHEZ

24 de Octubre de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 76.772.576,95 Euros. Resultante Suscrito: 10.846.909,75 Euros. Datos registrales. T2265 , F 138, S 8, H CO 1696, I/A 133 (17.10.16).

14 de Junio de 2016
Revocaciones. Apoderado: GADEA RAMOS MARIA LOURDES. Datos registrales. T 2265 , F 139, S 8, H CO 1696, I/A 132 (7.06.16).

03 de Marzo de 2016
Fusi贸n por uni贸n. Sociedades que se fusi贸nan: PRASA EJECUCION DE OBRAS SL. OUTSOURCING SEGUROS DE CORDOBANORTE SL. ESPACIO TURISTICO SOSTENIBLE SIERRA DE LA MOTA SL. PRASA CANARIAS SL. BENALUA SUR, SL.ARRENDAMIENTOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS SA. Datos registrales. T 2265 , F 134, S 8, H CO 1696, I/A 131 (25.02.16).

22 de Diciembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: CAMPANERO BRETONES MANUEL. Datos registrales. T 2265 , F 134, S 8, H CO 1696, I/A 130(15.12.15).

31 de Marzo de 2015
Revocaciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE AUDITORIA SA. Nombramientos. Auditor: ALCALA ZAMORA BARRON LUIS.Aud.Supl.: AGUERA JIMENEZ JUAN. Datos registrales. T 2265 , F 133, S 8, H CO 1696, I/A 129 (25.03.15).

19 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: CANO CABANILLAS RAQUEL. Datos registrales. T 2265 , F 133, S 8, H CO 1696, I/A 128 (13.11.14).

22 de Julio de 2014
Revocaciones. Apoderado: GENTIL ALCOBENDAS FRANCISCO;GENTIL ALCOBENDAS FRANCISCO. Datos registrales. T 2265, F 132, S 8, H CO 1696, I/A 127 (16.07.14).

16 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ CARRASCO JULIO. Datos registrales. T 2265 , F 132, S 8, H CO 1696, I/A 126 ( 9.06.14).

12 de Mayo de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 100.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 87.619.486,70 Euros. Datos registrales. T2265 , F 131, S 8, H CO 1696, I/A 125 ( 5.05.14).

06 de Febrero de 2013
Nombramientos. Auditor: ESPAUDIT GABINETE AUDITORIA SA. Datos registrales. T 2265 , F 131, S 8, H CO 1696, I/A 124(30.01.13).

15 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Auditor: AUDIBALANCE SL. Datos registrales. T 2265 , F 131, S 8, H CO 1696, I/A 123 ( 5.11.12).

17 de Febrero de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS;ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMERO GONZALEZJUANA;JORDAN CRESPO TEODOSIO ANTONIO. Datos registrales. T 1549 , F 225, S 8, H CO 1696, I/A 122 ( 8.02.12).

13 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS. Consejero: ROMERO GONZALEZ JUANA;ROMEROGONZALEZ JOSE. Presidente: ROMERO GONZALEZ JOSE. Consejero: ROMERO GONZALEZ PABLO;ROMERO GONZALEZCELEDONIO;ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS. Cons.Del.Sol: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS;ROMERO GONZALEZJOSE. SecreNoConsj: AMAYA GALVAN JOAQUIN ENRIQUE. Nombramientos. Adm. Unico: ROMERO GONZALEZ JOSE.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. 13.Administraci贸n y Representacion.-. 14. Administraci贸ny Representacion.-. 15. Administraci贸n y Representacion.-. 16. Administraci贸n yRepresentacion.-. 17. Administraci贸ny Representacion.-. 18. Administraci贸n y Representacion.-. 19. Administraci贸n y Representacion.-.Datos registrales. T 1549 , F 224, S 8, H CO 1696, I/A 121 ( 2.02.12).

22 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Auditor: AUDIBALANCE SL. Datos registrales. T 1549 , F 224, S 8, H CO 1696, I/A 119 (10.11.11).

30 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CRIADO BLANCO INMACULADA. Nombramientos. SecreNoConsj: AMAYA GALVANJOAQUIN ENRIQUE. Datos registrales. T 1549 , F 223, S 8, H CO 1696, I/A 118 (19.08.11).

22 de Julio de 2011
Nombramientos. Apoderado: LEON GALVIN RAFAEL. Datos registrales. T 1549 , F 223, S 8, H CO 1696, I/A 117 (14.07.11).

07 de Julio de 2011
Nombramientos. Apoderado: GENTIL ALCOBENDAS FRANCISCO. Datos registrales. T 1549 , F 222, S 8, H CO 1696, I/A 116(28.06.11).

24 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: MU脩OZ FERNANDEZ MARIA JOSE;CASADO PRADO GUILLERMO. Datos registrales. T 1549 , F 221,S 8, H CO 1696, I/A 115 (15.11.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n