Actos BORME de Grupo Transaher Sl
18 de Septiembre de 2023Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 73陋 el nombramiento de ESPEJO JIMENEZ RAQUEL, como ApoderadoMancomunado, siendo lo correcto Apoderado. Datos registrales. T 28953 , F 214, S 8, H M 169611, I/A 73 ( 4.02.21).
26 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28953 , F 217, S 8, H M 169611, I/A 77(18.03.21).
22 de Febrero de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.031,94 Euros. Resultante Suscrito: 14.232,30 Euros. Datos registrales. T 28953 , F 216,S 8, H M 169611, I/A 76 (15.02.21).
17 de Febrero de 2021Cambio de domicilio social. RONDA DE MARCOS ANA 6-8 (SAN FERNANDO DE HENARES). Datos registrales. T 28953 , F216, S 8, H M 169611, I/A 75 (10.02.21).
11 de Febrero de 2021Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ IVAN. Datos registrales. T 28953 , F 214, S 8, H M 169611, I/A 72 ( 4.02.21).
Nombramientos. Apo.Manc.: ESPEJO JIMENEZ RAQUEL. Datos registrales. T 28953 , F 214, S 8, H M 169611, I/A 73 ( 4.02.21).
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ VARGAS ESTHER. Datos registrales. T 28953 , F 215, S 8, H M 169611, I/A 74 ( 4.02.21).
04 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: GISMERO ANDUJAR FATIMA. Datos registrales. T 28953 , F 213, S 8, H M 169611, I/A 71(18.08.17).
17 de Abril de 2017Reelecciones. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28953 , F 213, S 8, H M 169611, I/A 70 (5.04.17).
16 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: ESPEJO JIMENEZ RAQUEL. Datos registrales. T 28953 , F 212, S 8, H M 169611, I/A 69 ( 7.03.16).
23 de Enero de 2015Reelecciones. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28953 , F 212, S 8, H M 169611, I/A 68(15.01.15).
28 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: SOLIS TORRES RAFAEL FRANCISCO. Datos registrales. T 28953 , F 211, S 8, H M 169611, I/A 66(16.04.14).
Nombramientos. Apoderado: PUIG DE TORRES DAVID JAIME. Datos registrales. T 28953 , F 211, S 8, H M 169611, I/A 67(16.04.14).
10 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 28953 , F 211, S 8, H M 169611, I/A 65 (2.07.13).
03 de Mayo de 2013Revocaciones. Apoderado: ESTEBAN PLATON EMILIO. Datos registrales. T 28953 , F 211, S 8, H M 169611, I/A 64 (23.04.13).
06 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ IVAN. Datos registrales. T 28953 , F 210, S 8, H M 169611, I/A 63(29.01.13).
02 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: GALINDO GONZALEZ CARLOS. Datos registrales. T 28953 , F 210, S 8, H M 169611, I/A 62(18.06.12).
08 de Septiembre de 2011Revocaciones. Apoderado: VALLESTIN LOPEZ ALBERTO;GONDRA FERNANDEZ IGNACIO;TRILLO OLIVER JUANPEDRO;SABATA DOMENECH JOSE. Datos registrales. T 28953 , F 210, S 8, H M 169611, I/A 61 (26.08.11).
26 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TRANSAHER CENTRAL DE LIQUIDACIONES SL. Representan: DIAZ BLASCO CRISTINA.Nombramientos. Adm. Unico: DIAZ BLASCO CRISTINA. Reelecciones. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP.Datos registrales. T 18524 , F 225, S 8, H M 169611, I/A 60 (12.08.11).
24 de Agosto de 2011Reelecciones. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 18524 , F 225, S 8, H M 169611, I/A 57(12.08.11).
Reelecciones. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 18524 , F 225, S 8, H M 169611, I/A 58(12.08.11).
Reelecciones. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 18524 , F 225, S 8, H M 169611, I/A 59(12.08.11).
18 de Mayo de 2010Cambio de domicilio social. AVDA DE EUROPA 9 (COSLADA). Datos registrales. T 18524 , F 225, S 8, H M 169611, I/A 56 (7.05.10).
05 de Marzo de 2009Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ ALONSO NICOLAS ANTONIO. Datos registrales. T 18524 , F 224, S 8, H M 169611, I/A55 (23.02.09).