Actos BORME de Grupo Tyrus Sl
13 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CRESPO BECERRIL JORGE. Nombramientos. Liquidador: CRESPO BECERRIL JORGE.Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 30845 , F 84, S 8, H M 555143, I/A 5 ( 3.11.23).
14 de Agosto de 2019Cambio de domicilio social. C/ ANGELITA CAVERO 13, - OFICINA 4 (MADRID). Datos registrales. T 30845 , F 84, S 8, H M555143, I/A 4 ( 7.08.19).
27 de Mayo de 2016Cambio de domicilio social. C/ LONDRES 38 - OFICINA 203, POLIGONO INDUSTRIAL E (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datosregistrales. T 30845 , F 84, S 8, H M 555143, I/A 3 (18.05.16).
21 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: MORENO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 30845 , F 84, S 8, H M 555143,I/A 2 (10.05.13).
21 de Marzo de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 6.03.13. Objeto social: LA VENTA AL POR MAYOR DE PIEZAS Y COMPONENTES DEAUTOMOCION. Domicilio: C/ ERATOSTENES 6 (GETAFE). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico:CRESPO BECERRIL JORGE. Nombramientos. Adm. Unico: CRESPO BECERRIL JORGE. Datos registrales. T 30845 , F 82, S 8,H M 555143, I/A 1 (12.03.13).