Buscador CIF Logo

Actos BORME Grupo Unigraf Servicios Generales Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Grupo Unigraf Servicios Generales Sl

Actos BORME Grupo Unigraf Servicios Generales Sl - B84507870

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Grupo Unigraf Servicios Generales Sl con CIF B84507870

馃敊 Perfil de Grupo Unigraf Servicios Generales Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Grupo Unigraf Servicios Generales Sl

19 de Mayo de 2023
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LANINVER SHC SL. Datos registrales. T 39117 , F 213, S 8, H M 392501, I/A 26(11.05.23).

13 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: VEGA DE CELIS ANA. Datos registrales. T 39117 , F 213, S 8, H M 392501, I/A 25 ( 5.10.22).

24 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: URANGA MURUZABAL JESUS;ODERIZ SAN MARTIN MIGUEL;BRAVO MORENO CARLOS;ORTEGAGUZMAN LAURA. Datos registrales. T 39117 , F 210, S 8, H M 392501, I/A 20 (17.12.21).

Nombramientos. Apoderado: BRAVO MORENO CARLOS. Datos registrales. T 39117 , F 211, S 8, H M 392501, I/A 21 (17.12.21).

Nombramientos. Apoderado: URANGA MURUZABAL JESUS. Datos registrales. T 39117 , F 211, S 8, H M 392501, I/A 22(17.12.21).

Nombramientos. Apoderado: ODERIZ SAN MARTIN MIGUEL. Datos registrales. T 39117 , F 212, S 8, H M 392501, I/A 23(17.12.21).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ODERIZ SAN MARTIN MIGUEL;URANGA MURUZABAL JESUS;BRAVO MORENO CARLOS. Datosregistrales. T 39117 , F 213, S 8, H M 392501, I/A 24 (17.12.21).

25 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GONZALEZ CUDEIRO FRANCISCO. Reelecciones. Adm. Mancom.: LANTERO MORENOANDRES;CARRE脩O ALVAREZ DANIEL. Datos registrales. T 39117 , F 209, S 8, H M 392501, I/A 18 (18.10.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ CUDEIRO FRANCISCO. Datos registrales. T 39117 , F 210, S 8, H M 392501, I/A 19(18.10.21).

22 de Julio de 2021
Nombramientos. Apoderado: VEGA DE CELIS ANA. Datos registrales. T 39117 , F 208, S 8, H M 392501, I/A 16 (15.07.21).

Nombramientos. Apoderado: OSMA HERNANDEZ JORGE. Datos registrales. T 39117 , F 209, S 8, H M 392501, I/A 17 (15.07.21).

29 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: LANTERO MORENO ANDRES;CARRE脩O ALVAREZ DANIEL. Datos registrales. T 22018 , F 154, S 8,H M 392501, I/A 15 (22.07.19).

15 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LANTERO MORENO ANDRES. Nombramientos. Adm. Mancom.: LANTERO MORENOANDRES;CARRE脩O ALVAREZ DANIEL;GONZALEZ CUDEIRO FRANCISCO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 22018 , F 154, S 8, H M 392501, I/A 14 (8.07.19).

11 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: LANTERO MORENO ANDRES;HOLZBACHER VALERO ENRIC;GONZALEZ CUDEIROFRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: LANTERO MORENO ANDRES. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 22018 , F 153, S 8, H M 392501, I/A 12 (3.12.18).

Revocaciones. Apo.Sol.: HOLZBACHER VALERO ENRIC;LANTERO MORENO ANDRES. Datos registrales. T 22018 , F 153, S 8,H M 392501, I/A 13 ( 3.12.18).

07 de Abril de 2017
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-LOECHES MARTINEZ CARLOS. Datos registrales. T 22018 , F 153, S 8, H M 392501,

23 de Diciembre de 2016
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 6潞 DE LOS ESTATUTOS. . Datos registrales. T 22018 , F 150, S 8,H M 392501, I/A 10 (16.12.16).

20 de Abril de 2016
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ CUDEIRO FRANCISCO;URANGAMURUZABAL JESUS;LANTERO MORENO ANDRES. Secretario: URANGA MURUZABAL JESUS. Presidente: GONZALEZ CUDEIROFRANCISCO. Con.Delegado: GONZALEZ CUDEIRO FRANCISCO. Consejero: HOLZBACHER VALERO ENRIC. Nombramientos.Adm. Mancom.: LANTERO MORENO ANDRES;HOLZBACHER VALERO ENRIC;GONZALEZ CUDEIRO FRANCISCO. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Cambio dedomicilio social. AVDA CAMARA DE LA INDUSTRIA 38 (MOSTOLES). Datos registrales. T 22018 , F 148, S 8, H M 392501, I/A 8(12.04.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: HOLZBACHER VALERO ENRIC;LANTERO MORENO ANDRES;GONZALEZ CUDEIRO FRANCISCO.Datos registrales. T 22018 , F 149, S 8, H M 392501, I/A 9 (12.04.16).

05 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MALLO CARCIOFFI JORGE. Cons.Del.Sol: MALLO CARCIOFFI JORGE. Nombramientos.Consejero: HOLZBACHER VALERO ENRIC. Datos registrales. T 22018 , F 148, S 8, H M 392501, I/A 7 (29.07.14).

24 de Junio de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REGO MARIA. Datos registrales. T 22018 , F 148, S 8, H M 392501, I/A 6 (17.06.13).

27 de Octubre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ BLASCO LUIS. Presidente: MALLO CARCIOFFI JORGE. Secretario: GUTIERREZBLASCO LUIS. Nombramientos. Consejero: LANTERO MORENO ANDRES. Secretario: URANGA MURUZABAL JESUS.Presidente: GONZALEZ CUDEIRO FRANCISCO. Con.Delegado: GONZALEZ CUDEIRO FRANCISCO. Datos registrales. T 22018 ,F 148, S 8, H M 392501, I/A 5 (15.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n