Actos BORME de Grupo Vivaltia Sl
17 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: AGUIRRE ALVAREZ JOSE IGNACIO;GOMEZ JIMENEZ JORGE. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n.Datos registrales. T 41914 , F 91, S 8, H M 742206, I/A 8 (10.01.22).
22 de Septiembre de 2021Modificaciones estatutarias. 9.Modificaci贸n texto art铆culo. Datos registrales. T 41914 , F 90, S 8, H M 742206, I/A 7 (15.09.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: LLINARES TARRI脩O JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 41914 , F 87, S 8, H M 742206, I/A 3(31.05.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: DEL CORRO GARCIA LOMAS JOSE MARIA. Datos registrales. T 41914 , F 87, S 8, H M 742206, I/A 4(31.05.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: AUTRAN PEREZ IGNACIO. Datos registrales. T 41914 , F 88, S 8, H M 742206, I/A 5 (31.05.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FILGUEIRA VICTOR. Datos registrales. T 41914 , F 88, S 8, H M 742206, I/A 6 (31.05.21).
28 de Mayo de 2021Modificaciones estatutarias. Aprobaci贸n de una nueva redacci贸n de los estatutos sociales. Cambio de domicilio social. AVDA DEBARAJAS 32 - -ACTUALMENTE DENOMINADA COMO (ALCOBENDAS). Cambio de objeto social. La prestaci贸n de toda claseservicios de telecomunicaciones a trav茅s de redes de comunicaci贸n electr贸nicas. El desarrollo de las infraestructuras necesarias parala creaci贸n de redes de comunicaci贸n por cualquier procedimiento inal谩mbrico o por cable... Datos registrales. T 41914 , F 83, S 8, HM 742206, I/A 2 (21.05.21).
22 de Enero de 2021Otros conceptos: Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberseexpedido con fecha de hoy certificaci贸n literal para traslado de domicilio social a Alcobendas - MADRID - Datos registrales. T 6764 ,F 16, S 8, H SE123005, I/A 3 D (14.01.21).
20 de Enero de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AVATEL TELECOM SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ MORENOJUAN ANTONIO;MORENO JIMENEZ PABLO;JIMENEZ JIMENEZ JUAN MANUEL;RODRIGUEZ MORENO MANUEL;JIMENEZJIMENEZ RAFAEL;JIMENEZ JIMENEZ ESPERANZA MACARENA;MORENO JIMENEZ MARIA JOSE;JIMENEZ JIMENEZ RUBEN.Con.Delegado: RODRIGUEZ MORENO JUAN ANTONIO. Presidente: MORENO JIMENEZ PABLO. Secretario: JIMENEZ JIMENEZJUAN MANUEL. Nombramientos. Adm. Solid.: AGUIRRE ALVAREZ JOSE IGNACIO;GOMEZ JIMENEZ JORGE. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 6764 , F 16, S 8,H SE123005, I/A 3 (13.01.21).
10 de Enero de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 255.160,00 Euros. Resultante Suscrito: 265.160,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6764 , F 14, S 8, H SE123005, I/A 2 (31.12.19).
11 de Septiembre de 2019Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.05.19. Objeto social: La participaci贸n en el capital social de entidades residentes y noresidentes en territorio espa帽ol, dirigiendo y gestionando dichas participaciones.- La prestaci贸n de servicios a las sociedadesparticipadas, consistentes en servicios de gesti贸n y administraci贸n, recursos humanos, contabilidad,... Domicilio: AVDA DELCOMERCIO 41-43 (VISO DEL ALCOR (EL)). Capital: 10.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ MORENO JUANANTONIO;MORENO JIMENEZ PABLO;JIMENEZ JIMENEZ JUAN MANUEL;RODRIGUEZ MORENO MANUEL;JIMENEZ JIMENEZRAFAEL;JIMENEZ JIMENEZ ESPERANZA MACARENA;MORENO JIMENEZ MARIA JOSE;JIMENEZ JIMENEZ RUBEN.Con.Delegado: RODRIGUEZ MORENO JUAN ANTONIO. Presidente: MORENO JIMENEZ PABLO. Secretario: JIMENEZ JIMENEZJUAN MANUEL. Datos registrales. T 6764 , F 11, S 8, H SE123005, I/A 1 ( 4.09.19).