Buscador CIF Logo

Actos BORME Gruporaga Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gruporaga Sa

Actos BORME Gruporaga Sa - A28317543

Tenemos registrados 79 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gruporaga Sa con CIF A28317543

馃敊 Perfil de Gruporaga Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gruporaga Sa

03 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: TEIXEIRA VITIENES JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 31069 , F 157, S 8, H M 67684, I/A 120(26.09.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: TRILLO PEREZ JAVIER. Datos registrales. T 31069 , F 157, S 8, H M 67684, I/A 121 (26.09.23).

01 de Junio de 2023
Nombramientos. Apoderado: BRU脩A LOPEZ ROBERTO. Datos registrales. T 31069 , F 155, S 8, H M 67684, I/A 119 (25.05.23).

11 de Abril de 2023
Nombramientos. Apoderado: TRILLO PEREZ JAVIER;MIJANGOS SAN MARTIN VICTORINO;MEDINA DE LA CRUZ RICARDO;DELA CRUZ CIELOS LUIS;AUTRAN PEREZ FERNANDO. Datos registrales. T 31069 , F 155, S 8, H M 67684, I/A 118 (30.03.23).

28 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: TEIXEIRA VITIENES JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 31069 , F 153, S 8, H M 67684, I/A 116(21.02.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ PINO IGNACIO ALBERTO. Datos registrales. T 31069 , F 155, S 8, H M 67684, I/A 117(21.02.23).

02 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: GARCIA FERNANDEZ ANDONI. Datos registrales. T 31069 , F 153, S 8, H M 67684, I/A 115(25.11.22).

31 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: PIMIENTO MIRANDA ISABEL;LEONOR CALLEJA BELEN;AUTRAN PEREZ FERNANDO. Datosregistrales. T 31069 , F 153, S 8, H M 67684, I/A 114 (24.10.22).

28 de Septiembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ GARCIA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 31069 , F 153, S 8, H M 67684, I/A 113(21.09.22).

08 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MORIN NAYRA;SANCHEZ POBRE MURILLO LUIS;BOTEY ALIER ALBERT. Datosregistrales. T 31069 , F 152, S 8, H M 67684, I/A 112 ( 1.04.22).

10 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO. Apo.Manc.: BARRERA GALINDEZ JUAN;BARRERA GALINDEZJUAN;BARRERA GALINDEZ JUAN. Datos registrales. T 31069 , F 151, S 8, H M 67684, I/A 109 ( 2.11.21).

Revocaciones. Apoderado: PEREZ DE LEMA SAENZ DE VIGUERA BORJA;PEREZ DE LEMA SAENZ DE VIGUERA BORJA.Apo.Manc.: PEREZ DE LEMA SAENZ DE VIGUERA BORJA. Datos registrales. T 31069 , F 152, S 8, H M 67684, I/A 110 ( 2.11.21).

Revocaciones. Apoderado: RAGA GARCIA GONZALO. Datos registrales. T 31069 , F 152, S 8, H M 67684, I/A 111 ( 2.11.21).

16 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: GARCIA FERNANDEZ ANDONI;OLIVAS AVELLO ALBERTO;LEONOR CALLEJA BELEN. Otrosconceptos: Revocada la facultad 16 del poder conferido en escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Jos茅 Lu铆s Martinez-GilVich, el 13-10-2020 con n煤mero 2.362 de protocolo, que caus贸 la inscripci贸n 98陋 de la hoja social. Datos registrales. T 31069 , F 151,S 8, H M 67684, I/A 108 ( 9.09.21).

24 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apoderado: DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Apo.Manc.: DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Apo.Sol.:DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 31069 , F 151, S 8, H M 67684, I/A 107 (17.05.21).

06 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PIMIENTO MIRANDA ISABEL. Nombramientos. Apo.Manc.: AUTRAN PEREZFERNANDO;LEONOR CALLEJA BELEN. Apo.Sol.: PIMIENTO MIRANDA ISABEL. Apo.Manc.: PIMIENTO MIRANDA ISABEL;OLIVASAVELLO ALBERTO. Datos registrales. T 31069 , F 149, S 8, H M 67684, I/A 105 (26.03.21).

Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ GARCIA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 31069 , F 151, S 8, H M 67684, I/A 106(26.03.21).

09 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MARTINEZ AGUSTIN. Datos registrales. T 31069 , F 148, S 8, H M 67684, I/A 103 (2.03.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: OLIVAS AVELLO ALBERTO;LEONOR CALLEJA BELEN. Datos registrales. T 31069 , F 148, S 8,H M 67684, I/A 104 ( 2.03.21).

03 de Febrero de 2021
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 31069 , F 148, S 8, H M 67684, I/A 102(27.01.21).

25 de Enero de 2021
Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31069 , F 148,S 8, H M 67684, I/A 101 (18.01.21).

11 de Enero de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ DE LEMA SAENZ DE VIGUERA BORJA. Datos registrales. T 31069 , F 147, S 8, H M 67684,I/A 100 (31.12.20).

11 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: OLIVAS AVELLO ALBERTO. Datos registrales. T 31069 , F 144, S 8, H M 67684, I/A 96 ( 3.11.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: TRILLO PEREZ JAVIER;MEDINA DE LA CRUZ RICARDO;DE LA CRUZ CIELOS LUIS;MIJANGOS SANMARTIN VICTORINO. Datos registrales. T 31069 , F 145, S 8, H M 67684, I/A 97 ( 3.11.20).

Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA FERNANDEZ ANDONI. Apo.Sol.: GARCIA FERNANDEZ ANDONI. Datos registrales. T31069 , F 145, S 8, H M 67684, I/A 98 ( 3.11.20).

Nombramientos. Apo.Manc.: DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Apo.Sol.: DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Datosregistrales. T 31069 , F 146, S 8, H M 67684, I/A 99 ( 3.11.20).

17 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PIMIENTO MIRANDA ISABEL. Apo.Manc.: PEREZ DE LEMA SAENZ DE VIGUERABORJA;LEONOR CALLEJA BELEN. Datos registrales. T 31069 , F 143, S 8, H M 67684, I/A 95 (10.09.20).

11 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ DE LEMA SAENZ DE VIGUERA BORJA;LEONOR CALLEJA BELEN. Datos registrales. T31069 , F 142, S 8, H M 67684, I/A 94 ( 4.09.20).

03 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: AUTRAN PEREZ FERNANDO. Datos registrales. T 31069 , F 141, S 8, H M 67684, I/A 93 (26.08.20).

03 de Julio de 2020
Reelecciones. Auditor: QUINTANA CARROZA ANGEL CARLOS. Aud.Supl.: RIERA BUENDIA JOAQUIN. Datos registrales. T31069 , F 140, S 8, H M 67684, I/A 92 (29.06.20).

02 de Junio de 2020
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 28/2. Datos registrales. T 31069 , F 140, S 8, H M 67684, I/A 91(26.05.20).

29 de Mayo de 2020
Revocaciones. Apoderado: GUZMAN SALDA脩A ADOLFO;VILLANUEVA CUEVA PABLO;BARRERA GALINDEZ JUANEUSEBIO;GARCIA GARCIA JORGE;RAGA GARCIA GONZALO;RAGA GARCIA GONZALO;BARRERA GALINDEZ JUANEUSEBIO;RAGA GARCIA FERNANDO;RAGA GARCIA GONZALO;RAGA GARCIA FERNANDO. Apo.Sol.: BARRERA GALINDEZJUAN EUSEBIO. Apo.Manc.: BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO. Apoderado: BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO;SOMOZAGARCIA FRANCISCO;PIMIENTO MIRANDA ISABEL;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS;BARRERA GALINDEZ JUANEUSEBIO;BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO;SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO;PIMIENTOMIRANDA ISABEL;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS;BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO;SERRANO CLAMAGIRANDDANIEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO;PIMIENTO MIRANDA ISABEL;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS;PIMIENTO MIRANDAISABEL;PIMIENTO MIRANDA ISABEL;BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO;RAGA GARCIA FERNANDO. Apo.Man.Soli:BARRERA GALINDEZ JUAN;SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO;PIMIENTO MIRANDAISABEL;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS;BARRERA GALINDEZ JUAN;SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL;SOMOZA GARCIAFRANCISCO;PIMIENTO MIRANDA ISABEL;DE DUE脩AS DOADRIO JUAN CARLOS. Apo.Manc.: BARRERA GALINDEZJUAN;PIMIENTO MIRANDA ISABEL;DE DUE脩AS DOADRIO JUAN CARLOS;BARRERA GALINDEZ JUAN;PIMIENTO MIRANDAISABEL;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Apo.Man.Soli: DE LA CRUZ CIELOS LUIS;MARTIN HERNANDEZ EUSEBIO ANTONIO.Apoderado: BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO;MARTIN HERNANDEZ EUSEBIO ANTONIO;RAGA GARCIA GONZALO;RAGAGARCIA GONZALO;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 31069 , F 139, S 8, H M 67684, I/A 90 (22.05.20).

26 de Mayo de 2020
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RICOTECA SERVICIOS Y GESTIONES SL. Ceses/Dimisiones. Presidente: RAGAGARCIA FERNANDO. Consejero: RAGA GARCIA GONZALO;RAGA GARCIA FERNANDO;PUERTA LOPEZ-COZAR ALEJANDRO.Secretario: PUERTA LOPEZ-COZAR ALEJANDRO. Nombramientos. Adm. Unico: RICOTECA SERVICIOS Y GESTIONES SL.Representan: ALFONSO AVELLO ANTONIO JOSE. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 16 Y 17 DELOS ESTATUTOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.Datos registrales. T 31069 , F 139, S 8, H M 67684, I/A 89 (19.05.20).

13 de Noviembre de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.793.823,80 Euros. Resultante Suscrito: 1.945.950,20 Euros. Datos registrales. T 31069, F 138, S 8, H M 67684, I/A 88 ( 5.11.18).

02 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: QUINTANA CARROZA ANGEL CARLOS. Aud.Supl.: RIERA BUENDIA JOAQUIN. Datos registrales. T31069 , F 138, S 8, H M 67684, I/A 87 (24.10.18).

30 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 31069 , F 137, S 8, H M 67684, I/A 86(23.10.18).

08 de Junio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO. Vicepresid.: BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO.Nombramientos. Apoderado: RAGA GARCIA GONZALO. Reelecciones. Presidente: RAGA GARCIA FERNANDO. Consejero:RAGA GARCIA GONZALO;RAGA GARCIA FERNANDO;PUERTA LOPEZ-COZAR ALEJANDRO. Secretario: PUERTA LOPEZ-COZAR ALEJANDRO. Datos registrales. T 31069 , F 137, S 8, H M 67684, I/A 85 ( 1.06.18).

19 de Abril de 2017
Revocaciones. Apoderado: GIRON IRALA ANDRES. Apo.Man.Soli: GIRON IRALA ANDRES. Apoderado: GIRON IRALA ANDRES.Datos registrales. T 31069 , F 137, S 8, H M 67684, I/A 84 (10.04.17).

14 de Marzo de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CASTELO TARDIO JULIO FRANCISCO. Datos registrales. T 31069 , F 137, S 8, H M 67684, I/A 83 (6.03.17).

27 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GUTIERREZ CANALEJO ANTONIO. Datos registrales. T 31069 , F 136, S 8, H M 67684, I/A 82(17.02.17).

28 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Auditor: BUENDIA FORTEA SALVADOR. Aud.Supl.: AVEVEDO HERANZ ELADIO. Nombramientos. Auditor:QUINTANA CARROZA ANGEL CARLOS. Aud.Supl.: RIERA BUENDIA JOAQUIN. Datos registrales. T 31069 , F 136, S 8, H M67684, I/A 81 (20.07.15).

20 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apoderado: SAEZ PALACIOS JUAN IGNACIO. Apo.Sol.: ORTEGA PONCE DE LEON FELIX;GIRON IRALAANDRES. Datos registrales. T 31069 , F 136, S 8, H M 67684, I/A 80 (12.03.15).

31 de Julio de 2014
Cambio de objeto social. A. La intervenci贸n sobre todo tipo de instalaciones, edificios, mobiliario, jardines y espacios naturales, en elejercicio de las siguientes actividades: 1. La prestaci贸n integral de servicios de limpieza en general, y especialmente en edificios,locales, f谩bricas, instalaciones industriales, medios. Datos registrales. T 31069 , F 135, S 8, H M 67684, I/A 79 (23.07.14).

05 de Marzo de 2014
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 269.984,00 Euros. Desembolsado: 269.984,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.739.774,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.739.774,00 Euros. Datos registrales. T 31069 , F 134, S 8, H M 67684, I/A 78 (25.02.14).

07 de Febrero de 2014
Nombramientos. Aud.Supl.: AVEVEDO HERANZ ELADIO. Reelecciones. Auditor: BUENDIA FORTEA SALVADOR. Datosregistrales. T 31069 , F 134, S 8, H M 67684, I/A 77 (30.01.14).

26 de Septiembre de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 58.810,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.469.790,00 Euros. Escisi贸n parcial. Sociedadesbeneficiarias de la escisi贸n: CONCESIONES DEPORTIVAS RAGA SL. Datos registrales. T 31069 , F 131, S 8, H M 67684, I/A 76(18.09.13).

09 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: RAGA GARCIA GONZALO. Datos registrales. T 31069 , F 130, S 8, H M 67684, I/A 75 (27.08.13).

20 de Junio de 2013
Nombramientos. Apoderado: RAGA GARCIA GONZALO. Datos registrales. T 25193 , F 159, S 8, H M 67684, I/A 74 (12.06.13).

19 de Junio de 2013
Otros conceptos: SOCIEDAD ESCINDIDA PARCIALMENTE:"GRUPORAGA SA",DOMICILIADA ENMADRID,C/EMBAJADORES,320, INS.R.M.DE MADRID, TOMO 4067,FOLIO 20,HOJA M-67.684,INS. 14&;SOCIEDAD BENEFICIARIADE LA ESCISION, LA COMPA脩IA DE NUEVA CREACION QUE SE DENOMINARA "CONCESIONES DEPORTIVAS RAGA SL".Datos registrales. T 4067 , F 20, S 8, H M 67684, I/A 14/M (12.06.13).

18 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL;GOMEZ PUYUELO FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado:RAGA GARCIA GONZALO. Reelecciones. Presidente: RAGA GARCIA FERNANDO. Consejero: RAGA GARCIAGONZALO;BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO;RAGA GARCIA FERNANDO;PUERTA LOPEZ-COZAR ALEJANDRO. Secretario:PUERTA LOPEZ-COZAR ALEJANDRO. Vicepresid.: BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO. Datos registrales. T 25193 , F 159, S8, H M 67684, I/A 73 ( 7.06.13).

04 de Marzo de 2013
Revocaciones. Apoderado: SOMOZA GARCIA FRANCISCO. Otros conceptos: Modificada la forma de Actuaci贸n de Do帽a IsabelPimiento Miranda, cuyo poder caus贸 la inscripci贸n 41& de la Hoja Social. Datos registrales. T 25193 , F 158, S 8, H M 67684, I/A 72(21.02.13).

15 de Febrero de 2013
Reelecciones. Auditor: BUENDIA FORTEA SALVADOR. Aud.Supl.: BUENDIA CALDERON SALVADOR. Datos registrales. T 25193, F 158, S 8, H M 67684, I/A 71 ( 7.02.13).

08 de Febrero de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDO PEREZ ANDRES ANGEL. Apo.Man.Soli: HERNANDO PEREZ ANDRES ANGEL. Datosregistrales. T 25193 , F 157, S 8, H M 67684, I/A 70 (31.01.13).

24 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: SOMOZA GARCIA FRANCISCO. Apo.Sol.: DE CAMPO CASADO OSCAR. Datos registrales. T 25193 ,F 157, S 8, H M 67684, I/A 68 (14.12.12).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ DE LEMA SAENZ DE VIGUERA BORJA;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS;GIRON IRALAANDRES;BARRERA GALINDEZ JUAN EUSEBIO;MEDINA DE LA CRUZ RICARDO;MARTIN HERNANDEZ EUSEBIO ANTONIO.Datos registrales. T 25193 , F 157, S 8, H M 67684, I/A 69 (14.12.12).

29 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: PEREZ DE LEMA SAENZ DE VIGUERA BORJA. Datos registrales. T 25193 , F 154, S 8, H M 67684,I/A 66 (14.11.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIRON IRALA ANDRES. Datos registrales. T 25193 , F 155, S 8, H M 67684, I/A 67 (14.11.12).

23 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO. Otros conceptos: Modificado elpoder que caus贸 la inscripci贸n 42& exclusivamente la forma mancomunada de actuar del apoderado Don Juan Carlos Due帽asDoadrio.- Datos registrales. T 25193 , F 148, S 8, H M 67684, I/A 59 (13.11.12).

Revocaciones. Apoderado: SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO. Otros conceptos: Modificado elpoder que caus贸 la inscripci贸n 36& exclusivamente la forma mancomunada de actuar del apoderado Don Juan Eusebio BarreraGal铆ndez.- Datos registrales. T 25193 , F 148, S 8, H M 67684, I/A 60 (13.11.12).

Revocaciones. Apo.Manc.: SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO. Otros conceptos: Modificado elpoder que caus贸 la inscripci贸n 56& exclusivamente la forma mancomunada de actuar del apoderado Don Andr茅sAngel HernandoP茅rez.- Datos registrales. T 25193 , F 149, S 8, H M 67684, I/A 62 (13.11.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA CRUZ CIELOS LUIS. Apo.Manc.: BARRERA GALINDEZ JUAN;PIMIENTO MIRANDAISABEL;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 25193 , F 150, S 8, H M 67684, I/A 63 (13.11.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN HERNANDEZ EUSEBIO ANTONIO. Apo.Manc.: BARRERA GALINDEZ JUAN;PIMIENTOMIRANDA ISABEL;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 25193 , F 151, S 8, H M 67684, I/A 64 (13.11.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MEDINA DE LA CRUZ RICARDO. Apo.Manc.: BARRERA GALINDEZ JUAN;PIMIENTO MIRANDAISABEL;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 25193 , F 152, S 8, H M 67684, I/A 65 (13.11.12).

Revocaciones. Apo.Manc.: SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO. Otros conceptos: Modificado elpoder que caus贸 la inscripci贸n 57& exclusivamente la forma mancomunada de actuar del apoderado Don Julio Francisco CasteloTardio.- Datos registrales. T 25193 , F 149, S 8, H M 67684, I/A 61 (13.11.12).

16 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL. Apo.Manc.: SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL. Apoderado:SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL;NUEVO GARCIA JAVIER;SOMOZA GARCIA FRANCISCO;NUEVO GARCIA JAVIER;SERRANOCLAMAGIRAND DANIEL. Apo.Man.Soli: NUEVO GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 25193 , F 148, S 8, H M 67684, I/A 58 (5.11.12).

20 de Abril de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NUEVO GARCIA JAVIER;BARRERA GALINDEZ JUAN;SERRANO CLAMAGIRANDDANIEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO;PIMIENTO MIRANDA ISABEL;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T25193 , F 137, S 8, H M 67684, I/A 54 (10.04.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUTIERREZ CANALEJO ANTONIO;BARRERA GALINDEZ JUAN;SERRANO CLAMAGIRANDDANIEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO;PIMIENTO MIRANDA ISABEL;DE DUE脩AS DOADRIO JUAN CARLOS. Datos registrales.T 25193 , F 139, S 8, H M 67684, I/A 55 (10.04.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDO PEREZ ANDRES ANGEL;BARRERA GALINDEZ JUAN;SERRANO CLAMAGIRANDDANIEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO;PIMIENTO MIRANDA ISABEL;DE DUE脩AS DOADRIO JUAN CARLOS. Datos registrales.T 25193 , F 142, S 8, H M 67684, I/A 56 (10.04.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTELO TARDIO JULIO FRANCISCO;BARRERA GALINDEZ JUAN;SERRANO CLAMAGIRANDDANIEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO;PIMIENTO MIRANDA ISABEL;DUE脩AS DOADRIO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T25193 , F 145, S 8, H M 67684, I/A 57 (10.04.12).

15 de Marzo de 2012
Ampliacion del objeto social. SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS,EVENTOS ASAMBLEAS O SIMILARES. GUIAS DE TURISMO. PRESTACION DE SERVICIOS DETRADUCCION... Datosregistrales. T 25193 , F 136, S 8, H M 67684, I/A 53 ( 5.03.12).

11 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: BUENDIA FORTEA SALVADOR. Aud.Supl.: BUENDIA CALDERON SALVADOR. Datos registrales. T 25193, F 136, S 8, H M 67684, I/A 52 (29.12.11).

04 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Consejero: GOMEZ PUYUELO FRANCISCO JAVIER. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 528.600,00 Euros.Desembolsado: 528.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.528.600,00 Euros. Resultante Desembolsado: 3.528.600,00 Euros. Datosregistrales. T 25193 , F 134, S 8, H M 67684, I/A 50 (24.10.11).

Ampliacion del objeto social. LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE OBRA PUBLICA, PRIVADA YLACONTRATACION, GESTION, PROYECTO, CONSTRUCCION, MONTAJE, INSTALACION, EJECUCION Y MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA ASI COMO PROYECTOS LLAVE EN MANO... Datos registrales. T 25193 , F 135, S 8, H M 67684, I/A 51 (24.10.11).

18 de Marzo de 2011
Ampliacion del objeto social. La gesti贸n de servicios p煤blicos de depuraci贸n de aguas residuales.La contrucci贸n, explotaci贸n ygesti贸n de instalaciones de aguas residuales.La gesti贸n, tratamiento y valorizaci贸n de lodos. La construcci贸n de obras hidr谩ulicas..Laconstrucci贸n de puentes, viaductos..Trabajos de conservaci贸n y mante. Datos registrales. T 25193 , F 133, S 8, H M 67684, I/A 49 (8.03.11).

04 de Enero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.810.640,00 Euros. Desembolsado: 2.810.640,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 25193 , F 133, S 8, H M 67684, I/A 48 (21.12.09).

05 de Junio de 2009
Reelecciones. Auditor: BUENDIA FORTEA SALVADOR. Aud.Supl.: BUENDIA CALDERON SALVADOR. Datos registrales. T 25193, F 133, S 8, H M 67684, I/A 47 (26.05.09).

25 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apoderado: RAGA GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 25193 , F 132, S 8, H M 67684, I/A 46 (13.05.09).

18 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: DE CAMPO CASADO OSCAR;ORTEGA PONCE DE LEON FELIX;HERNANDO PEREZ ANDRESANGEL;GIRON IRALA ANDRES. Datos registrales. T 25193 , F 132, S 8, H M 67684, I/A 45 ( 9.02.09).

12 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: PIMIENTO MIRANDA ISABEL;SOMOZA GARCIA FRANCISCO;NUEVO GARCIA JAVIER;BARRERAGALINDEZ JUAN EUSEBIO;SERRANO CLAMAGIRAND DANIEL. Datos registrales. T 25193 , F 131, S 8, H M 67684, I/A 44 (2.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n