Actos BORME de Gruvi 21 Sl
26 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: VISEDO RODRIGUEZ ANA-BEGO脩A;RODRIGUEZ GOMEZ ANA-MARIA. Nombramientos.Apo.Man.Soli: VISEDO RODRIGUEZ ANA-BEGO脩A;VISEDO RODRIGUEZ GUILLERMO;FRANCISCO JAVIER VISEDORODRIGUEZ. Datos registrales. T 14322 , F 205, S 8, H M 236317, I/A 11 (19.04.23).
24 de Enero de 2023Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.750.000,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.750.000,00 Euros. Datos registrales. T 14322 , F 203, S 8, H M 236317, I/A 10(17.01.23).
16 de Septiembre de 2022Cambio de domicilio social. PASEO DE LOS PARQUES 7 - PORTAL 11 PISO 2 D (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 14322 ,F 203, S 8, H M 236317, I/A 9 ( 9.09.22).
17 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: VISEDO NAVARRO GUILLERMO. Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 8陋 el cesecomo Consejero de VISEDO RODRIGUEZ GUILLERMO, siendo lo correcto VISEDO NAVARRO GUILLERMO. Datos registrales. T14322 , F 203, S 8, H M 236317, I/A 8 (25.09.18).
02 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: VISEDO RODRIGUEZ GUILLERMO. Datos registrales. T 14322 , F 203, S 8, H M 236317, I/A 8(25.09.18).
29 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: VISEDO RODRIGUEZ ANA BEGO脩A. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ GOMEZ ANA MARIA;VISEDONAVARRO GUILLERMO;RODRIGUEZ GOMEZ ANA MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: VISEDO RODRIGUEZ ANA-BEGO脩A;RODRIGUEZ GOMEZ ANA-MARIA. Datos registrales. T 14322 , F 202, S 8, H M 236317, I/A 7 (19.09.11).
29 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: VISEDO RODRIGUEZ GUILLERMO. Nombramientos. Secretario: VISEDO RODRIGUEZFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 14322 , F 201, S 8, H M 236317, I/A 6 (10.06.11).