Actos BORME de Gryphon Management Spain Sl
23 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: ELENA QUINTAS ROBLES;ALVARO JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ. Nombramientos. Apo.Manc.:JOAQUIN BAUTISTA MI脩ANO. Apo.Man.Soli: ANDREA BECERRA ROBLEDILLO. Apo.Manc.: STUART GERARD KIRKPATRICK.Datos registrales. T 2393 , F 117, S 8, H CA 58432, I/A 7 (16.10.23).
07 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO JESUS. Datos registrales. T 2393 , F 115, S 8, H CA 58432, I/A
20 de Abril de 2022Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2393 , F 115, S 8, H CA 58432, I/A 5 ( 5.04.22).
17 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: BENZ DOMINIK FRANK. Cons.Del.Man: BENZ DOMINIK FRANK. Nombramientos. Consejero:RACIC DOMINIK. Cons.Del.Man: RACIC DOMINIK. Datos registrales. T 2393 , F 115, S 8, H CA 58432, I/A 4 ( 9.03.22).
30 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: EKBERG PETER MICHAEL. Cons.Del.Man: EKBERG PETER MICHAEL. Revocaciones.Apo.Manc.: EKBERG PETER MICHAEL;RUFATTO BARBARA MARIA LOUISE KALLIN;RUFATTO BARBARA MARIA LOUISKALIN;SCHARTNER MANFRED. Nombramientos. Consejero: BENZ DOMINIK FRANK. Cons.Del.Man: BENZ DOMINIK FRANK.Datos registrales. T 2393 , F 113, S 8, H CA 58432, I/A 3 (23.08.21).
11 de Mayo de 2021Cambio de domicilio social. CTRA MALAGA 16 - POL. INDUSTRIAL EL ZABAL (LINEA DE LA CONCEPCION (LA)). Datosregistrales. T 2393 , F 112, S 8, H CA 58432, I/A 2 (30.04.21).
26 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: QUINTAS ROBLES ELENA;FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO JESUS. Datos registrales. T 38247, F 74, S 8, H M 680545, I/A 7 (18.03.21).
24 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO JESUS;WIMMER BIRGIT. Apo.Manc.: PRESCHRYSZARD;EKBERG PETER MICHAEL;SCHARTNER MANFRED;RUFATTO BARBARA MARIA LOUIS KALIN. Apo.Sol.: PORRASPEDRAZA JUAN;DE LA CRUZ MURIE JOSE LUIS. Datos registrales. T 38247 , F 73, S 8, H M 680545, I/A 6 (17.09.20).
09 de Julio de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.900.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 38247 , F 72, S8, H M 680545, I/A 5 ( 2.07.20).
26 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ESTALELLA CARVAJAL JAIME. Presidente: ESTALELLA CARVAJAL JAIME. Consejero: RODRIGOGOMEZ OLGA MARIA;SCHARTNER MANFRED. Secretario: RIESGO VARELA MARCELO. Revocaciones. Apo.Sol.: ESTALELLACARVAJAL JAIME. Apo.Manc.: ESTALELLA CARVAJAL JAIME. Apo.Sol.: RODRIGO GOMEZ OLGA MARIA. Apo.Manc.: RODRIGOGOMEZ OLGA MARIA. Apo.Sol.: SCHARTNER MANFRED. Apo.Manc.: SCHARTNER MANFRED. Nombramientos. SecreNoConsj:LAWYERS AND ACCOUNTANTS SL. Consejero: PRESCH RYSZARD;EKBERG PETER MICHAEL;WIMMER BIRGIT. Cons.Del.Man:PRESCH RYSZARD;EKBERG PETER MICHAEL;WIMMER BIRGIT. Representan: PORRAS PEDRAZA JUAN. Presidente: WIMMERBIRGIT. Datos registrales. T 38247 , F 70, S 8, H M 680545, I/A 3 (19.02.20).
Nombramientos. Apo.Manc.: SCHARTNER MANFRED;RUFATTO BARBARA MARIA LOUISE KALLIN. Datos registrales. T 38247 ,F 71, S 8, H M 680545, I/A 4 (19.02.20).
25 de Octubre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ESTALELLA CARVAJAL JAIME. Apo.Manc.: ESTALELLA CARVAJAL JAIME. Apo.Sol.: RODRIGOGOMEZ OLGA MARIA. Apo.Manc.: RODRIGO GOMEZ OLGA MARIA. Apo.Sol.: SCHARTNER MANFRED. Apo.Manc.: SCHARTNERMANFRED. Datos registrales. T 38247 , F 69, S 8, H M 680545, I/A 2 (18.10.18).
24 de Octubre de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 24.09.18. Objeto social: La adquisici贸n, suscripci贸n, tenencia, disfrute y enajenaci贸n porcualquier t铆tulo de cualesquiera bienes muebles, acciones y participaciones sociales de sociedades mercantiles en general, tantonacionales como extranjeras, as铆 como la direcci贸n, gesti贸n, control y administraci贸n de su cartera. Domicilio: C/ GALILEO GALILEI 28- POLIGONO INDUSTRIAL "LA GA (ALCALA DE HENARES). Capital: 100.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio煤nico: GRYPHON INVEST AG. Nombramientos. Consejero: ESTALELLA CARVAJAL JAIME. Presidente: ESTALELLA CARVAJALJAIME. Consejero: RODRIGO GOMEZ OLGA MARIA;SCHARTNER MANFRED. Secretario: RIESGO VARELA MARCELO. Datosregistrales. T 38247 , F 68, S 8, H M 680545, I/A 1 (17.10.18).