Actos BORME de Gsm Hoteles Sa
23 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MU脩OZ APARICIO ROSA MARIA. Revocaciones. Apoderado: MARTIN GONZALEZ JOSEMANUEL;TOBA QUINTANS MANUEL. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 562/2022. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n20/09/2022. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 17 DE MADRID.Juez: SOFIA GIL GARCIA. Resoluciones: Se declara en concurso de acreedores de la mercantil GSM HOTELES SA. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 562/2022. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 20/09/2022. Auto de conclusi贸n del concurso.Cumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 17 DE MADRID. Juez: SOFIA GIL GARCIA.Resoluciones: Se declara la conclusi贸n del concurso de acreedores y se acuerda la extinci贸n de la misma. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 562/2022. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 20/09/2022. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸nde las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 17 DEMADRID. Juez: SOFIA GIL GARCIA. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 18738 , F 129, S 8, H M 21117, I/A 13(16.12.22).
10 de Agosto de 2021Reelecciones. Adm. Unico: MU脩OZ APARICIO ROSA MARIA. Datos registrales. T 18738 , F 129, S 8, H M 21117, I/A 12 (3.08.21).
29 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN GONZALEZ JOSE MANUEL;MU脩OZ APARICIO ROSA MARIA;SILES MU脩OZ IVAN.Presidente: MU脩OZ APARICIO ROSA MARIA. Secretario: MARTIN GONZALEZ JOSE MANUEL. Con.Delegado: MU脩OZ APARICIOROSA MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: MU脩OZ APARICIO ROSA MARIA. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Adaptaci贸n a la Ley de Sociedades de Capital. Cambio dedomicilio social. C/ SANTO ANGEL 81 3潞 A (MADRID). Datos registrales. T 18738 , F 126, S 8, H M 21117, I/A 11 (20.01.15).
15 de Enero de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 898,79 Euros. Desembolsado: 898,79 Euros. Resultante Suscrito: 61.000,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 61.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 120.231,00 Euros. Desembolsado: 120.231,00 Euros. ResultanteSuscrito: 181.231,00 Euros. Resultante Desembolsado: 181.231,00 Euros. Datos registrales. T 18738 , F 126, S 8, H M 21117, I/A 10( 4.01.13).
11 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: SILES PEREZ CASTILLA DEMETRIO. Presidente: SILES PEREZ CASTILLA DEMETRIO. Consejero:MARTIN GONZALEZ JOSE MANUEL. Secretario: MARTIN GONZALEZ JOSE MANUEL. Consejero: MU脩OZ APARICIO ROSAMARIA. Con.Delegado: SILES PEREZ CASTILLA DEMETRIO. Nombramientos. Consejero: MARTIN GONZALEZ JOSEMANUEL;MU脩OZ APARICIO ROSA MARIA;SILES MU脩OZ IVAN. Presidente: MU脩OZ APARICIO ROSA MARIA. Secretario: MARTINGONZALEZ JOSE MANUEL. Con.Delegado: MU脩OZ APARICIO ROSA MARIA. Datos registrales. T 18738 , F 125, S 8, H M 21117,I/A 9 (28.07.10).