Buscador CIF Logo

Actos BORME Gts Thaumat Xxi Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gts Thaumat Xxi Sociedad Anonima

Actos BORME Gts Thaumat Xxi Sociedad Anonima - A95350666

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Vizcaya para Gts Thaumat Xxi Sociedad Anonima con CIF A95350666

馃敊 Perfil de Gts Thaumat Xxi Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Vizcaya

Actos BORME de Gts Thaumat Xxi Sociedad Anonima

19 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: MAROTO BOHOYO JESUS. Datos registrales. T 4749 , F 80, S 8, H BI 41813, I/A 34 (11.12.23).

05 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: BELLSOLELL GOMIS JORDI. Datos registrales. T 4749 , F 79, S 8, H BI 41813, I/A 33 (23.11.23).

08 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: HERRANZ CID JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4515 , F 42, S 8, H BI 41813, I/A 31 (26.10.23).

05 de Octubre de 2023
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: EZENTIS SOLUCIONES TECNOLOGICAS E INGENIERIA SOCIE.Datos registrales. T 4515 , F 42, S 8, H BI 41813, I/A 30 (27.09.23).

04 de Abril de 2023
Cambio de domicilio social. C/ AZBARREN 3 - NAVE 4D, PLANTA BAJA (BASAURI). Datos registrales. T 4515 , F 41, S 8, H BI41813, I/A 28 (28.03.23).

14 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: ROBLES ALVAREZ OSCAR. Datos registrales. T 4515 , F 41, S 8, H BI 41813, I/A 27 ( 6.02.23).

02 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apoderado: ARANGUREN ORIOL LUIS MARIA. Datos registrales. T 4515 , F 41, S 8, H BI 41813, I/A 26(23.01.23).

03 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ MARTIN TAMARA. Datos registrales. T 4515 , F 41, S 8, H BI 41813, I/A 25 (27.12.22).

30 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: MALDONADO CARRASCO JOSE MARIA. Datos registrales. T 4515 , F 41, S 8, H BI 41813, I/A 24(16.12.22).

23 de Junio de 2022
Revocaciones. Apoderado: MARI脩AS LAGE CARLOS. Datos registrales. T 4515 , F 40, S 8, H BI 41813, I/A 23 (15.06.22).

31 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: BARON LOPEZ IGNACIO;BETANCOR SANTANA PEDRO. Datos registrales. T 4515 , F 40, S 8, H BI41813, I/A 21 (22.03.22).

20 de Enero de 2022
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 4515 , F 40, S 8, H BI 41813, I/A 19(12.01.22).

07 de Julio de 2021
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: EZENTIS FIELD FACTORY SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 4515 , F 32, S 8, H BI 41813, I/A 16 (29.06.21).

Nombramientos. Apoderado: ROBLES ALVAREZ OSCAR. Datos registrales. T 4515 , F 32, S 8, H BI 41813, I/A 17 (29.06.21).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTIN TAMARA. Datos registrales. T 4515 , F 38, S 8, H BI 41813, I/A 18 (29.06.21).

04 de Enero de 2021
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CORPORACION EZENTIS INTERNACIONAL S.A.R.L. Datosregistrales. T 4515 , F 32, S 8, H BI 41813, I/A 15 (22.12.20).

28 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: BETANCOR SANTANA PEDRO. Datos registrales. T 4515 , F 30, S 8, H BI 41813, I/A 14 (17.09.20).

18 de Diciembre de 2018
Fe de erratas: En el borme 204 de 2017. referencia 419138, se public贸 la inscripci贸n 11陋, siendo lo correcto nota marginal al margede la inscripci贸n 1陋. Datos registrales. T 4514 , F 225, S 8, H BI 41813, I/A 1. m (17.10.17).

03 de Diciembre de 2018
Fe de erratas: La emisi贸n del titlulo multiple n潞 1 motiv贸 nota marginal al margen de la inscripci贸n primera. Datos registrales. T 4514, F 222, S 8, H BI 41813, I/A 1. m (17.10.17).

26 de Noviembre de 2018
Fe de erratas: La inscripci贸n de 20 de veinte de febrero de 2018, es la inscripci贸n 11 y no la 12 como se hizo constar por error.Datos registrales. T 4514 , F 224, S 8, H BI 41813, I/A 11 . (20.02.18).

16 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: BARON LOPEZ IGNACIO. Datos registrales. T 4514 , F 225, S 8, H BI 41813, I/A 13 ( 6.11.18).

Fe de erratas: La inscripci贸n de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho corresponde a la inscripci贸n 11 y no la 12 como se hizoconstar por error. Datos registrales. T 4514 , F 224, S 8, H BI 41813, I/A 11 . (20.02.18).

06 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO. Presidente: GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO. Consejero:MARI脩AS LAGE CARLOS;GOMEZ FERNANDEZ JOSE LUIS. Con.Delegado: GOMEZ FERNANDEZ JOSE LUIS. SecreNoConsj: DECASSO PEREZ JORGE. VsecrNoConsj: BARRIO FERNANDEZ JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO EZENTISSOCIEDAD ANONIMA. Otros conceptos: Art铆culo de los estatutos: Modificados los art铆culos 12潞, 20潞 y 22潞 de los estatutos relativosal 贸rgano de administraci贸n. La duraci贸n del 贸rgano de administraci贸n ser谩 de seis a帽os. Datos registrales. T 4514 , F 225, S 8, H BI41813, I/A 12 (25.10.18).

01 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apoderado: MAROTO BOHOYO JESUS. Datos registrales. T 4514 , F 224, S 8, H BI 41813, I/A 12 (20.02.18).

25 de Octubre de 2017
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: EZENTIS TECNOLOGIA SL. Datos registrales. T 4514 , F 224, S 8, H BI 41813, I/A9 (17.10.17).

Modificaciones estatutarias. se modifica el art. 10 de los estatutos.. Datos registrales. T 4514 , F 224, S 8, H BI 41813, I/A 10(17.10.17).

Otros conceptos: emitido un t铆tulo m煤ltiple n煤mero uno representativo de las 100.000 acciones nominativas de la Sociedad. Datosregistrales. T 4514 , F 224, S 8, H BI 41813, I/A 11 (17.10.17).

27 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: OCHOA CALVO JOSE MANUEL. Presidente: OCHOA CALVO JOSE MANUEL. Consejero: SAENZMORENO JUAN MANUEL. Secretario: SAENZ MORENO JUAN MANUEL. Consejero: UNZURRUNZAGA ORTEGA JESUS MARIA.Nombramientos. Consejero: GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO. Presidente: GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO. Consejero:MARI脩AS LAGE CARLOS;FERNANDEZ GOMEZ JOSE LUIS. Con.Delegado: FERNANDEZ GOMEZ JOSE LUIS. Apoderado:GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO;MARI脩AS LAGE CARLOS;MALDONADO CARRASCO JOSE MARIA;MERINO LANZA MANUEL.SecreNoConsj: DE CASSO PEREZ JORGE. Datos registrales. T 4514 , F 223, S 8, H BI 41813, I/A 8 (14.09.17).

05 de Enero de 2016
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL ITZAGA , PARCELA E1 (GALDAKAO). Datos registrales. T 4514 , F 222, S 8, HBI 41813, I/A 7 (23.12.15).

21 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAENZ MORENO JUAN MANUEL. Presidente: SAENZ MORENO JUAN MANUEL. Consejero:UNZURRUNZAGA ORTEGA JESUS MARIA. Secretario: UNZURRUNZAGA ORTEGA JESUS MARIA. Consejero: RUIZ DE AZUABASARRATE ALFREDO. Nombramientos. Consejero: OCHOA CALVO JOSE MANUEL. Presidente: OCHOA CALVO JOSEMANUEL. Consejero: SAENZ MORENO JUAN MANUEL. Secretario: SAENZ MORENO JUAN MANUEL. Consejero:UNZURRUNZAGA ORTEGA JESUS MARIA. Datos registrales. T 4514 , F 222, S 8, H BI 41813, I/A 6 (14.08.15).

31 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAENZ MORENO JUAN MANUEL. Presidente: SAENZ MORENO JUAN MANUEL. Consejero: RUIZDE AZUA BASARRATE ALFREDO. Co.De.Ma.So: SAENZ MORENO JUAN MANUEL;RUIZ DE AZUA BASARRATE ALFREDO.Consejero: UNZURRUNZAGA ORTEGA JESUS MARIA. Secretario: UNZURRUNZAGA ORTEGA JESUS MARIA. Nombramientos.Consejero: SAENZ MORENO JUAN MANUEL. Presidente: SAENZ MORENO JUAN MANUEL. Consejero: UNZURRUNZAGAORTEGA JESUS MARIA. Secretario: UNZURRUNZAGA ORTEGA JESUS MARIA. Consejero: RUIZ DE AZUA BASARRATEALFREDO. Datos registrales. T 4514 , F 222, S 8, H BI 41813, I/A 5 (15.12.10).

26 de Abril de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ MERINO RAUL. Secretario: GOMEZ MERINO RAUL. Co.De.Ma.So: GOMEZ MERINORAUL. Nombramientos. Consejero: UNZURRUNZAGA ORTEGA JESUS MARIA. Secretario: UNZURRUNZAGA ORTEGA JESUSMARIA. Apo.Man.Soli: NAVARRO RODRIGUEZ FELIPE;PEREZ DE EULATE ALBIZU FERNANDO. Datos registrales. T 4514 , F221, S 8, H BI 41813, I/A 4 (13.04.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n