Actos BORME de Guadarrama Formacion Profesional Sl
07 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: SANTACREU BARRON DIEGO;DOMINGUEZ GIMENEZ JOAQUIN;MALAGA GARCIAESTHER;RIVILLA VELASCO JUAN CARLOS;QUEREJETA BANDEIRA SOFIA;JULIA GARCIA LUZ;PI脩EIRO LOPEZ MARIAGORETTI;RUANO ARJONILLA ITZIAR;PERANCHO RUIZ PABLO. Datos registrales. T 40956 , F 189, S 8, H M 711426, I/A 15(31.07.23).
18 de Julio de 2023Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 40956 , F 189, S 8, H M 711426, I/A 14 (11.07.23).
14 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO;JIMENEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO;VERDUFERNANDEZ DIEGO JOSE. Nombramientos. Apoderado: QUEREJETA BANDEIRA SOFIA. Datos registrales. T 40956 , F 188, S8, H M 711426, I/A 11 ( 7.03.22).
04 de Mayo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MOLINA GIMENEZ MARIA ELENA;PUJANTE PEREZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 40041 ,F 38, S 8, H M 711426, I/A 10 (23.04.21).
30 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MOLINA GIMENEZ MARIA ELENA;PUJANTE PEREZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos.Apoderado: ROJAS RIBAYO JESUS IGNACIO. Datos registrales. T 40041 , F 38, S 8, H M 711426, I/A 10 (23.04.21).
01 de Diciembre de 2020Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 40041 , F 37, S 8, H M 711426, I/A 9 (24.11.20).
12 de Junio de 2020Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 13潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 40041 ,F 37, S 8, H M 711426, I/A 8 ( 5.06.20).
17 de Marzo de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MOLINA GIMENEZ MARIA ELENA;PUJANTE PEREZ FRANCISCO JAVIER;JIMENEZ HERNANDEZJUAN FRANCISCO;VERDU FERNANDEZ DIEGO JOSE. Datos registrales. T 40041 , F 35, S 8, H M 711426, I/A 7 (10.03.20).
16 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: ARBIDE ESTENSORO JUAN. Nombramientos. Representan: CANO LUCAYA JAVIER. Datosregistrales. T 40041 , F 35, S 8, H M 711426, I/A 6 ( 9.03.20).
24 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MOLINA GIMENEZ MARIA ELENA;PUJANTE PEREZ FRANCISCO JAVIER;JIMENEZ HERNANDEZJUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 40041 , F 34, S 8, H M 711426, I/A 5 (17.02.20).
14 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: ARBIDE ESTENSORO JUAN;ARTOLA BOOGEN EUGENIA ANA;LUJAMBIO LLAMASJULIO;GONZALEZ MOSQUEIRA PABLO;GOMEZ APOLINARIO FRANCISCO-JOSE;GIL-CASARES MILANS DE BOSCH BORJAMARIA;BENBUNAN FERREIRO MOISES;DE LA FUENTE ZARATIEGUI JOSE LUIS. Datos registrales. T 40041 , F 32, S 8, H M711426, I/A 2 ( 7.02.20).
Nombramientos. Apoderado: DE LOS REYES CALVO DAVID. Datos registrales. T 40041 , F 33, S 8, H M 711426, I/A 3 ( 7.02.20).
Cambio de domicilio social. AVDA DE LA UNIVERSIDAD 1 (VILLANUEVA DE LA CA脩ADA). Datos registrales. T 40041 , F 34, S8, H M 711426, I/A 4 ( 7.02.20).
10 de Enero de 2020Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 18.11.19. Objeto social: La Sociedad tiene como objeto social: a) La compra, venta, gesti贸ny negociaci贸n de toda clase de valores, t铆tulos y activos mobiliarios por cuenta propia y en especial, la adquisici贸n y mantenimiento departicipaciones en el capital o recursos propios de entidades que tengan por objeto el ... Domicilio: C/ DE PRINCIPE DE VERGARA112 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GUADARRAMA PROYECTOSEDUCATIVOS SL. Nombramientos. Representan: ARBIDE ESTENSORO JUAN. Adm. Unico: GUADARRAMA PROYECTOSEDUCATIVOS SL. Datos registrales. T 40041 , F 30, S 8, H M 711426, I/A 1 (27.12.19).