Actos BORME de Guamar Sa
30 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTIN RUBIO ANTOLIN. Nombramientos. Consejero: MARTIN RUBIO ANTOLIN;MARTINSANCHEZ BEATRIZ;MARTIN SANCHEZ CRISTINA;MATEOS SANCHEZ RODOLFO;FRADEJA LOPEZ JORGE;CODESFERNANDEZ-CAVADA BORJA. Presidente: MARTIN RUBIO ANTOLIN. Vicepresid.: MATEOS SANCHEZ RODOLFO. SecreNoConsj:BEIGVEDER MONTERO ALEJANDRO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 5104, L 4011, F 11, S 8, H MA 1070, I/A 67 (21.12.22).
Nombramientos. Con.Delegado: MARTIN RUBIO ANTOLIN. PresEjecutiv: MARTIN RUBIO ANTOLIN. Datos registrales. T 5104, L4011, F 11, S 8, H MA 1070, I/A 68 (21.12.22).
30 de Noviembre de 2022Otros conceptos: Se modifican la totalidad de los estatutos sociales. Datos registrales. T 5104, L 4011, F 8, S 8, H MA 1070, I/A 66(21.11.22).
22 de Julio de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 13.063,00 Euros. Desembolsado: 13.063,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.223.463,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.223.463,00 Euros. Datos registrales. T 5104, L 4011, F 8, S 8, H MA 1070, I/A 65 (12.07.22).
29 de Diciembre de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 6.942,00 Euros. Desembolsado: 6.942,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.210.400,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.210.400,00 Euros. Otros conceptos: Cambio del valor, n煤mero y numeraci贸n de las participaciones enque se divide el capital social.- Datos registrales. T 5104, L 4011, F 7, S 8, H MA 1070, I/A 64 (21.12.21).
19 de Mayo de 2021Nombramientos. Auditor: EUDITA CYE AUDITORES SA. Datos registrales. T 5104, L 4011, F 7, S 8, H MA 1070, I/A 63 (10.05.21).
27 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: PEDROSA AGUILAR JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 5104, L 4011, F 7, S 8, H MA 1070, I/A62 (19.04.21).
01 de Febrero de 2021Reelecciones. Adm. Unico: MARTIN RUBIO ANTOLIN. Datos registrales. T 5104, L 4011, F 7, S 8, H MA 1070, I/A 61 (22.01.21).
10 de Mayo de 2018Nombramientos. Auditor: EUDITA CYE AUDITORES SA. Datos registrales. T 5104, L 4011, F 7, S 8, H MA 1070, I/A 60 (27.04.18).
09 de Marzo de 2016Reelecciones. Adm. Unico: MARTIN RUBIO ANTOLIN. Datos registrales. T 5104, L 4011, F 6, S 8, H MA 1070, I/A 59 ( 1.03.16).
25 de Junio de 2015Revocaciones. Auditor: HISPACONTROL AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: EUDITA CYE AUDITORES SA. Datosregistrales. T 5104, L 4011, F 6, S 8, H MA 1070, I/A 58 (17.06.15).
17 de Abril de 2013Reelecciones. Auditor: HISPACONTROL AUDITORES SL. Datos registrales. T 5104, L 4011, F 6, S 8, H MA 1070, I/A 57(11.04.13).
27 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: MARTIN SANCHEZ MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 1842, L 755, F 133, S 8, H MA 1070, I/A50 (20.02.13).
Nombramientos. Apoderado: CODES FERNANDEZ-CAVADA BORJA. Datos registrales. T 1842, L 755, F 133, S 8, H MA 1070, I/A51 (20.02.13).
Nombramientos. Apoderado: FRAJEDA LOPEZ JORGE. Datos registrales. T 1842, L 755, F 134, S 8, H MA 1070, I/A 52(20.02.13).
Nombramientos. Apoderado: MATEOS SANCHEZ RODOLFO. Datos registrales. T 1842, L 755, F 134, S 8, H MA 1070, I/A 53(20.02.13).
Revocaciones. Apoderado: MATEOS SANCHEZ RODOLFO;FRADEJA LOPEZ JORGE. Datos registrales. T 1842, L 755, F 134, S8, H MA 1070, I/A 54 (20.02.13).
Nombramientos. Apoderado: DUARTE DE HARO PEDRO. Datos registrales. T 5104, L 4011, F 6, S 8, H MA 1070, I/A 55(20.02.13).
28 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: FRADEJA LOPEZ JORGE. Datos registrales. T 1842, L 755, F 133, S 8, H MA 1070, I/A 49(14.03.11).
28 de Febrero de 2011Reelecciones. Adm. Unico: MARTIN RUBIO ANTOLIN. Datos registrales. T 1842, L 755, F 133, S 8, H MA 1070, I/A 48 (18.02.11).
20 de Diciembre de 2010Nombramientos. Auditor: HISPACONTROL AUDITORES SL. Datos registrales. T 1842, L 755, F 133, S 8, H MA 1070, I/A 47(25.11.10).
01 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: MATEOS SANCHEZ RODOLFO. Datos registrales. T 1842, L 755, F 132, S 8, H MA 1070, I/A 46(19.06.09).