Actos BORME de Guia De Apartamentos Niumba Sl
01 de Junio de 2023Revocaciones. APODERAD.SOL: SAMANTHA BABER;AYALA MU脩OZ LOURDES;SENDAGORTA CARSI DIANA;RODRIGUEZSAN JOSE ALBERTO;RODRIGUEZ GARCIA MARTA;TINTORE EYRIES MARIA DE LA PALOMA;BALLESTEROS MATILLAANTONIO JULIAN. Datos registrales. T 41215 , F 70, S 8, H B 321334, I/A 20 (25.05.23).
04 de Junio de 2020Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: DERMOT MARK HALPIN. Datos registrales. T 41215 , F 70, S 8, H B 321334, I/A 19 (28.05.20).
13 de Diciembre de 2019Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: STEPHEN KAUFER. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: LINDA CRISTINE FRAZIER. Datosregistrales. T 41215 , F 70, S 8, H B 321334, I/A 18 ( 4.12.19).
10 de Agosto de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: AYALA MU脩OZ LOURDES;SENDAGORTA CARSI DIANA;RODRIGUEZ SAN JOSEALBERTO;RODRIGUEZ GARCIA MARTA;TINTORE EYRIES MARIA DE LA PALOMA;BALLESTEROS MATILLA ANTONIO JULIAN.Datos registrales. T 41215 , F 69, S 8, H B 321334, I/A 17 ( 3.08.17).
21 de Julio de 2016Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: JULIE MARIE BRADLEY. Cambio de domicilio social. CL AUSIAS MARCH, NUMERO 148-150PLANTA 4-7 (BARCELONA). Datos registrales. T 41215 , F 69, S 8, H B 321334, I/A 16 (12.07.16).
09 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: ANEGON NU脩EZ ALBA LAURA;EGUZQUIZA SOLIS ANA MARIA;VAZQUEZ OTEO FRANCISCOJAVIER;DANCAUSA VALLE ENRIQUE;LUNA SALCINES CAMILO;VAZQUEZ DE PRADA BENNASAR EDUARDO MARCOS;RUIZTRUJILLO JESUS. Nombramientos. Apo.Sol.: ESCRIBANO CA脩AS BLANCA;FONTANALS DE MIGUEL SOFIA;GARCIA-GASCOROMERO MARCOS;SEOANE LACAIO RAMON. Datos registrales. T 31457 , F 41, S 8, H M 566224, I/A 7 ( 1.06.16).
17 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: KALVERT SETH JONATHAN. Revocaciones. Apo.Sol.: DEES JONATHAN PATRICK;CRUZALIAGA JUAN. Nombramientos. Adm. Solid.: KALVERT SETH JONATHAN;BRADLEY JULIE MARIE;KAUFER STEPHEN;HALPINDERMOT MARK. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Quedamodificado el poder conferido a DO脩A SAMANTHA BABER, mediante escritura otorgada el 1 de septiembre de 2.014, ante el Notariode Madrid, Don Jose Angel Mart铆nez Sanchiz, con el n潞 1429 de su protocolo que caus贸 la inscripci贸n 4& en la hoja de la Sociedad, alque se le da nueva redacci贸n. Datos registrales. T 31457 , F 40, S 8, H M 566224, I/A 6 ( 9.12.14).
01 de Octubre de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 10.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.001,00 Euros. Datos registrales. T 31457 , F 40,S 8, H M 566224, I/A 5 (23.09.14).
26 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ MARTIN ANTONIO IGNACIO. Apo.Sol.: ALONSO PARDOS BEATRIZ. Nombramientos.Apo.Sol.: DEES JONATHAN PATRICK;CRUZ ALIAGA JUAN;CHAYTOR ALISTAIR;DEES JONATHAN PATRICK;CRUZ ALIAGAJUAN;BABER SAMANTHA;CHAYTOR ALISTAIR. Otros conceptos: Revocado el poder conferido a favor de do帽a Mar铆a Jos茅Gonz谩lez Barros Bellsol谩, otorgado mediante escritura autorizada ante el notario de Barcelona, don Antonio Bosch Carrera, n煤mero1914 de su protocolo, y que caus贸 la inscripci贸n 5& de las de Barcelona, transcrita por la 1& de Madrid.- Datos registrales. T 31457 ,F 39, S 8, H M 566224, I/A 4 (19.09.14).
10 de Octubre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: BULLOCK SHONA;BABER SAMANTHA;ALONSO PARDOS BEATRIZ. Datos registrales. T 31457 , F38, S 8, H M 566224, I/A 3 ( 2.10.13).
30 de Septiembre de 2013Cambio de domicilio social. C/ AGUSTIN DE FOXA 25 2 B (MADRID). Datos registrales. T 31457 , F 38, S 8, H M 566224, I/A 2(19.09.13).
14 de Agosto de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 40.001,00 Euros. Datos registrales. T 41215 , F 64, S 8, H B321334, I/A 9 ( 7.08.13).
30 de Julio de 2013Nombramientos. APODERAD.SOL: ANEGON NU脩EZ ALBA LAURA;EGUZQUIZA SOLIS ANA MARIA;VAZQUEZ OTEOFRANCISCO JAVIER;DANCAUSA VALLE ENRIQUE;LUNA SALCINES CAMILO;VAZQUEZ DE PRADA BENNASAR EDUARDOMARCOS;RUIZ TRUJILLO JESUS. Datos registrales. T 41215 , F 64, S 8, H B 321334, I/A 8 (22.07.13).
10 de Junio de 2013Revocaciones. ADM.UNICO: INTERCOM FACTORY SL. REPR.143 RRM: GONZALEZ BARROS BELLSOLA MARIA JOSE.Nombramientos. ADM.UNICO: SETH JONATHAN KALVERT. Otros conceptos: DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL SOCIO UNICO:TRIPADVISOR UK HOLDCO LIMITED. Datos registrales. T 41215 , F 64, S 8, H B 321334, I/A 7(30.05.13).
11 de Mayo de 2010Revocaciones. REPR.143 RRM: LANAS MARTIN ROMO FRANCISCO JOSE. Nombramientos. REPR.143 RRM: GONZALEZBARROS BELLSOLA MARIA JOSE. Datos registrales. T 41215 , F 63, S 8, H B 321334, I/A 6 (28.04.10).
25 de Agosto de 2009Nombramientos. APODERADO: SANCHEZ MARTIN ANTONIO IGNACIO;GONZALEZ BARROS MARIA JOSE. Datos registrales.T 41215 , F 61, S 8, H B 321334, I/A 5 (13.08.09).
03 de Junio de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 17.935,00 Euros. Resultante Suscrito: 40.000,00 Euros. Datos registrales. T 38169 , F 125, S 8, H B321334, I/A 4 (22.05.09).
20 de Abril de 2009Revocaciones. ADM.UNICO: GONZALEZ BARROS BELLSOLA IGNACIO. Nombramientos. ADM.UNICO: INTERCOM FACTORYSL. REPR.143 RRM: LANAS MARTIN ROMO FRANCISCO JOSE. Ampliaci贸n de capital. Capital: 7.065,00 Euros. ResultanteSuscrito: 22.065,00 Euros. Datos registrales. T 38169 , F 123, S 8, H B 321334, I/A 3 ( 6.04.09).