Actos BORME de Gunalta Itg Sl
23 de Agosto de 2023Revocaciones. Apoderado: BOLA脩A HERRERO MAURICIO;LINDNER MAXIMILIAN;TAULLET FERRANDO EDUARDO;FRAGADIAZ-CHIRON JUAN FRANCISCO. Apo.Sol.: REYES RAMIREZ LEONARDO;RIVERA PEREZ ANGEL. Datos registrales. T 37492 ,F 221, S 8, H M 668318, I/A 29 (16.08.23).
24 de Julio de 2023Cambio de domicilio social. AVDA DE BRUSELAS 24 1潞 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 37492 , F 221, S 8, H M 668318,I/A 28 (17.07.23).
24 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: LATORRE MARLASCA JUAN MARIA;FERNANDEZ POMARES JUAN;SANTIAGO PEREZANTONIO;MATA CISTER GUILLERMO. Modificaciones estatutarias. 7. Modificaci贸n del art铆culo 7 de los estatutos relativo a la
16 de Marzo de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre deEjercicio: 31/1. Datos registrales. T 37492 , F 212, S 8, H M 668318, I/A 25 ( 9.03.23).
09 de Marzo de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GLOBAL FONTIBRE SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: BOLA脩AHERRERO MAURICIO;CROSBIE MARK JOHN;LINDNER MAXIMILIAN;TAULET FERRANDO EDUARDO;AGUILAR FERNANDEZHONTORIA EDUARDO;FRAGA DIAZ-CHIRON JUAN FRANCISCO. Presidente: TAULET FERRANDO EDUARDO. Consejero: LOPEZMU脩OZ JOSE ANTONIO;HUMM PHILIPP RUDOLF;AHARONIAN ARAM. Con.Delegado: LOPEZ MU脩OZ JOSE-ANTONIO.SecreNoConsj: GARCIA-NIETO NUBIOLA PABLO. VsecrNoConsj: DE LEYVA MERIDA AMPARO. Nombramientos. Adm. Mancom.:LOPEZ MU脩OZ JOSE-ANTONIO;BOTELLA PEDRAZA ALVARO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejode administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 37492 , F 211, S 8, H M 668318, I/A 24 ( 2.03.23).
24 de Agosto de 2022Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 7陋 el poder otorgado a RIVERA PEREZ ANGEL debiendo quedar anulado. Datosregistrales. T 37492 , F 76, S 8, H M 668318, I/A 6 ( 6.08.18).
Nombramientos. Apoderado: RIVERA PEREZ ANGEL. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 6陋 la publicaci贸n delpoder otorgado a RIVERA PEREZ ANGEL. Datos registrales. T 37492 , F 76, S 8, H M 668318, I/A 6 ( 6.08.18).
22 de Julio de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 37492 , F 211, S 8, H M 668318, I/A 23 (15.07.22).
26 de Mayo de 2022Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 18陋 la reelecci贸n del Auditor de Cuentas para el a帽o 2021, siendo lo correcto parael a帽o 20/21. Datos registrales. T 37492 , F 205, S 8, H M 668318, I/A 18 (15.07.21).
25 de Mayo de 2022Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 21陋 el nombramiento de LEYVA MERIDA AMPARO como SECRETARIO NOCONSEJERO, siendo lo correcto VICESECRETARIO NO CONSEJERO. Datos registrales. T 37492 , F 209, S 8, H M 668318, I/A 21( 2.02.22).
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: LYNTIA NETWORKS HOLDING SL. Datos registrales. T 37492 , F 209, S 8, H M668318, I/A 22 (18.05.22).
09 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: CABEZUELA GONZALEZ OSCAR. Nombramientos. SecreNoConsj: DE LEYVA MERIDAAMPARO. Datos registrales. T 37492 , F 209, S 8, H M 668318, I/A 21 ( 2.02.22).
12 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ MU脩OZ JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 37492 , F 208, S 8, H M 668318, I/A 20 (3.11.21).
01 de Octubre de 2021Nombramientos. Con.Delegado: LOPEZ MU脩OZ JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 37492 , F 206, S 8, H M 668318, I/A 19(24.09.21).
22 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: SODER SIMON. Nombramientos. Consejero: AHARONIAN ARAM. Reelecciones. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Modificacionesestatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 20 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 37492 , F 205, S 8, H M 668318, I/A 18(15.07.21).
26 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ ANTONIO JESUS;LINDNER MAXIMILIAN;LOPEZ SANCHEZ MARIAENCARNACION;DIAZ SANCHEZ SANDRA MARIA. Datos registrales. T 37492 , F 205, S 8, H M 668318, I/A 17 (19.08.20).
27 de Febrero de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 97.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.597.800,00 Euros. Datos registrales. T 37492 , F 203, S 8,H M 668318, I/A 15 (20.02.20).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 261.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.858.800,00 Euros. Datos registrales. T 37492 , F 204, S 8,H M 668318, I/A 16 (20.02.20).
05 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: REYES RAMIREZ LEONARDO. Datos registrales. T 37492 , F 203, S 8, H M 668318, I/A 14 (28.10.19).
27 de Septiembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 37492 , F 202, S 8,H M 668318, I/A 13 (20.09.19).
06 de Agosto de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.100.000,00 Euros. Datos registrales. T 37492 , F 200, S 8,H M 668318, I/A 12 (30.07.19).
29 de Abril de 2019Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LAREMUNERACION DE LOS ADMINISTRADORES. Datos registrales. T 37492 , F 200, S 8, H M 668318, I/A 11 (22.04.19).
07 de Diciembre de 2018Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 259D 44 (MADRID). Datos registrales. T 37492 , F 79, S 8, H M668318, I/A 10 (29.11.18).
04 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTEGA MARTINEZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 37492 , F 79, S 8, H M 668318, I/A 8(26.11.18).
14 de Noviembre de 2018Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: LOPEZ MU脩OZ JOSE ANTONIO;HUMMPHILIPP RUDOLF. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Otros conceptos: Fijado en nueve el n煤merode miembros del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 37492 , F 79, S 8, H M 668318, I/A 7 ( 6.11.18).
17 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: BOLA脩A HERRERO MAURICIO;LINDNER MAXIMILIAN;TAULLET FERRANDO EDUARDO;FRAGADIAZ-CHIRON JUAN FRANCISCO;RIVERA PEREZ ANGEL;ORTEGA MARTINEZ ANTONIO JESUS;REYES RAMIREZ LEONARDO.Datos registrales. T 37492 , F 76, S 8, H M 668318, I/A 6 ( 6.08.18).
16 de Agosto de 2018Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 7潞 Y 8潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T37492 , F 73, S 8, H M 668318, I/A 3 ( 6.08.18).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 997.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 37492 , F 74, S 8,H M 668318, I/A 4 ( 6.08.18).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BOLA脩A HERRERO MAURICIO. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA NIETO NUBIOLAPABLO. VsecrNoConsj: CABEZUELA GONZALEZ OSCAR. Consejero: BOLA脩A HERRERO MAURICIO;CROSBIE MARKJOHN;LINDNER MAXIMILIAN;SODER SIMON;TAULET FERRANDO EDUARDO;AGUILAR FERNANDEZ HONTORIAEDUARDO;FRAGA DIAZ-CHIRON JUAN FRANCISCO. Presidente: TAULET FERRANDO EDUARDO. Modificaciones estatutarias.SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 4潞, 20潞 Y 24潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/7. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social.C/ MANUEL SILVELA 13 (MADRID). Datos registrales. T 37492 , F 74, S 8, H M 668318, I/A 5 ( 6.08.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARRALDA CABANAS LUCIA;DE LEYVA MERIDA AMPARO;SEGURA DE LA MONJA IGNACIO. Datosregistrales. T 37492 , F 76, S 8, H M 668318, I/A 5 ( 6.08.18).
06 de Julio de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ANTIN INFRASTRUCTURE LUXEMBOURG III.7 SARL.Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: INTERTRUST (SPAIN) SL. Representan: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. Nombramientos.Adm. Unico: BOLA脩A HERRERO MAURICIO. Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 63 (MADRID). Datos registrales. T37492 , F 72, S 8, H M 668318, I/A 2 (28.06.18).
11 de Abril de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.03.18. Objeto social: La adquisici贸n tenencia, disfrute y administraci贸n, direcci贸n ygesti贸n de t铆tulos valores y/o acciones representativas de los fondos propios de sociedades o entidades constituidas en territorio