Actos BORME de Gv48 Capital Sl
05 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: SANZ CA脩ADAS INMACULADA. Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN MARTIN JOSE MARIA;ESCODAPUENTE CARLOS. Datos registrales. T 40231 , F 85, S 8, H M 608673, I/A 12 (28.09.22).
26 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRER VARGAS CARLOS. Nombramientos. Apoderado: SANZ CA脩ADAS INMACULADA. Datosregistrales. T 40231 , F 85, S 8, H M 608673, I/A 11 (19.05.22).
11 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: FERRER VARGAS CARLOS. Datos registrales. T 33823 , F 67, S 8, H M 608673, I/A 10 ( 4.03.20).
10 de Enero de 2020Revocaciones. Apoderado: VENTERO MU脩OZ ALVARO. Datos registrales. T 33823 , F 67, S 8, H M 608673, I/A 9 (27.12.19).
14 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: RIBADULLA INVERSIONESSL. Representan: GARCIA LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 33823 , F 66, S 8, H M 608673, I/A 7 ( 7.03.19).
Nombramientos. Apoderado: VENTERO MU脩OZ ALVARO. Datos registrales. T 33823 , F 66, S 8, H M 608673, I/A 8 ( 7.03.19).
04 de Marzo de 2019Ampliacion del objeto social. Servicios integrales a edificios e instalaciones. Alojamientos tur铆sticos y otros alojamientos de cortaestancia. Datos registrales. T 33823 , F 65, S 8, H M 608673, I/A 6 (25.02.19).
26 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS. Datos registrales. T 33823 , F 64, S 8, H M 608673, I/A 5(19.09.18).
04 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: GARCIA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.Consejero: PRADAS GOMEZ RICARDO. Vicepresid.: PRADAS GOMEZ RICARDO. Consejero: DE MIGUEL QUEREJETA AGUSTIN.Secretario: DE MIGUEL QUEREJETA AGUSTIN. Consejero: RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS. Vicesecret.: RODRIGUEZARRANZ FERNANDO LUIS. Cons.Del.Sol: GARCIA LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA LOPEZFRANCISCO JAVIER. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.Datos registrales. T 33823 , F 64, S 8, H M 608673, I/A 4 (22.06.18).
28 de Febrero de 2018Cambio de domicilio social. C/ GRAN VIA NUMERO 51, PISO 4潞 A (MADRID). Datos registrales. T 33823 , F 64, S 8, H M608673, I/A 3 (21.02.18).
29 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Representan: RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS. Adm. Solid.: PRADAS GOMEZ RICARDO;TECNICASHIT MANDRIL SL. Nombramientos. Consejero: GARCIA LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: GARCIA LOPEZ FRANCISCOJAVIER. Consejero: PRADAS GOMEZ RICARDO. Vicepresid.: PRADAS GOMEZ RICARDO. Consejero: DE MIGUEL QUEREJETAAGUSTIN. Secretario: DE MIGUEL QUEREJETA AGUSTIN. Consejero: RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS. Vicesecret.:RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS. Cons.Del.Sol: GARCIA LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 33823 , F 63, S 8, H M608673, I/A 2 (21.07.16).
16 de Septiembre de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 5.08.15. Objeto social: 1.- La adquisici贸n, venta y arrendamiento de toda clase de bienesinmuebles y fincas r煤sticas y urbanas, as铆 como la gestion y administraci贸n de las mismas. 2.- Estudio, asesoramiento, gestion einformaci贸n a terceros de toda clase de negocios, empresas y operaciones industriales. Domicilio: C/ SAN MARCOS 8 1 A (MADRID).Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: PRADAS GOMEZ RICARDO;TECNICAS HIT MANDRIL SL. Representan:RODRIGUEZ ARRANZ FERNANDO LUIS. Datos registrales. T 33823 , F 59, S 8, H M 608673, I/A 1 ( 4.09.15).