Buscador CIF Logo

Actos BORME Gvc Gaesco Correduria De Seguros Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gvc Gaesco Correduria De Seguros Sa

Actos BORME Gvc Gaesco Correduria De Seguros Sa - A59086223

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Gvc Gaesco Correduria De Seguros Sa con CIF A59086223

馃敊 Perfil de Gvc Gaesco Correduria De Seguros Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Gvc Gaesco Correduria De Seguros Sa

11 de Diciembre de 2023
Revocaciones. REPR.143 RRM: GARCIA PALACIO ENRIQUE. Nombramientos. REPR.143 RRM: VALLVE RIBERA ANGELS.Datos registrales. T 44595 , F 156, S 8, H B 63954, I/A 44 (30.11.23).

23 de Marzo de 2022
Revocaciones. REPR.143 RRM: DOMENECH ZAMORA LLUIS. Nombramientos. REPR.143 RRM: GARCIA PALACIO ENRIQUE.Datos registrales. T 44595 , F 156, S 8, H B 63954, I/A 43 (16.03.22).

02 de Marzo de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 44595 , F 155, S 8, H B63954, I/A 42 (22.02.21).

10 de Noviembre de 2020
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: PANTOJA TURIEGANO ANTONIO. Datos registrales. T 44595 , F 155, S 8, H B 63954, I/A 41(29.10.20).

13 de Agosto de 2020
Nombramientos. APOD.MANCOMU: PANTOJA TURIEGANO ANTONIO;MARTINEZ HERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T44595 , F 154, S 8, H B 63954, I/A 40 ( 5.08.20).

11 de Agosto de 2020
Fe de erratas: En el BORME no.47/2019 y con referencia 108196 EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL APODERADO SR. ENRIQUE ESENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ. Datos registrales. T 44595 , F 153, S 8, H B 63954, I/A 37 ( 1.03.19).

21 de Octubre de 2019
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: ABEJARO SERRANO MIGUEL. Datos registrales. T 44595 , F 154, S 8, H B 63954, I/A 39(11.10.19).

02 de Septiembre de 2019
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44595 , F 154, S 8, H B 63954, I/A 38 (23.08.19).

08 de Marzo de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: COSTA FREIXA JOAN;MARATINEZ HERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 44595 , F153, S 8, H B 63954, I/A 37 ( 1.03.19).

22 de Febrero de 2019
Nombramientos. APOD.MANCOMU: PANTOJA TURIEGANO ANTONIO;MARTINEZ HERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T44595 , F 153, S 8, H B 63954, I/A 36 (14.02.19).

08 de Febrero de 2019
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44595 , F 153, S 8, H B 63954, I/A 35 (30.01.19).

23 de Enero de 2019
Nombramientos. ADM.UNICO: GVC GAESCO HOLDING SL. REPR.143 RRM: DOMENECH ZAMORA LLUIS. Datos registrales. T44595 , F 152, S 8, H B 63954, I/A 34 (15.01.19).

19 de Diciembre de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44595 , F 152, S 8, H B 63954, I/A 33 ( 5.12.17).

07 de Octubre de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44595 , F 152, S 8, H B 63954, I/A 32 (29.09.16).

23 de Octubre de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44595 , F 151, S 8, H B 63954, I/A 31 (15.10.15).

16 de Julio de 2015
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ABEJARO SERRANO MIGUEL. Datos registrales. T 44595 , F 151, S 8, H B 63954, I/A 30 (8.07.15).

09 de Diciembre de 2014
Nombramientos. APOD.MANCOMU: SECANELL VILADOT JOSE MARIA;BERGE ATSERIAS XAVIER. Datos registrales. T 44595 ,F 151, S 8, H B 63954, I/A 29 (28.11.14).

20 de Noviembre de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 23975 , F 106, S 8, H B 63954, I/A 28 (13.11.14).

27 de Febrero de 2014
Nombramientos. ADM.UNICO: GVC GAESCO HOLDING SL. REPR.143 RRM: DOMENECH ZAMORA LLUIS. Datos registrales. T23975 , F 106, S 8, H B 63954, I/A 26 (19.02.14).

Revocaciones. APODERADO: BERMUDEZ PEREZ RAFAEL. Nombramientos. APOD.MANCOMU: BERGE ATSERIAS XAVIER.Datos registrales. T 23975 , F 106, S 8, H B 63954, I/A 27 (19.02.14).

10 de Diciembre de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 23975 , F 105, S 8, H B 63954, I/A 25 (29.11.13).

07 de Noviembre de 2012
Cambio de domicilio social. CL DOCTOR FERRAN 3-5 P.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 23975 , F 105, S 8, H B 63954,I/A 24 (25.10.12).

10 de Julio de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 85.001,70 Euros. Resultante Suscrito: 65.001,30 Euros. Datos registrales. T 23975 , F104, S 8, H B 63954, I/A 23 (28.06.12).

13 de Mayo de 2011
Revocaciones. APODERADO: MARTINEZ GARCIA JUAN. Datos registrales. T 23975 , F 104, S 8, H B 63954, I/A 22 ( 2.05.11).

29 de Noviembre de 2010
Revocaciones. AUDIT.CUENT.: MORISON AC SL. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 23975 ,F 103, S 8, H B 63954, I/A 21 (17.11.10).

27 de Noviembre de 2009
Nombramientos. APODERADO: MARTINEZ GARCIA JUAN. Datos registrales. T 23975 , F 103, S 8, H B 63954, I/A 20 (17.11.09).

25 de Marzo de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: MORISON AC SL. Datos registrales. T 23975 , F 103, S 8, H B 63954, I/A 19 (12.03.09).

10 de Marzo de 2009
Nombramientos. APODERADO: SECANELL VILADOT JOSE MARIA;BERMUDEZ PEREZ RAFAEL. Datos registrales. T 23975 , F102, S 8, H B 63954, I/A 18 (26.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n