Buscador CIF Logo

Actos BORME Harinera De Tardienta Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Harinera De Tardienta Sa

Actos BORME Harinera De Tardienta Sa - A22001499

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Huesca para Harinera De Tardienta Sa con CIF A22001499

馃敊 Perfil de Harinera De Tardienta Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Huesca

Actos BORME de Harinera De Tardienta Sa

18 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AYECHU REDIN JUAN MARIA. Revocaciones. Apo.Manc.: ROYO GOLDARACENA I脩IGO.Apo.Sol.: ROYO GOLDARACENA I脩IGO;LARRAYA IRIARTE MARIO;LIMON MACIAS JUAN LUIS. Apo.Manc.: LARRAYA IRIARTEMARIO;LIMON MACIAS JUAN LUIS;PLO SUSIN JORGE. Apo.Sol.: PLO SUSIN JORGE. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datosregistrales. T 529 , F 187, S 8, H HU 1673, I/A 94 (10.10.23).

08 de Junio de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: ROYO GOLDARACENA I脩IGO. Apo.Manc.: ROYO GOLDARACENA I脩IGO;SANCHEZ PEMAN JAVIERMARIA. Apo.Sol.: SANCHEZ PEMAN JAVIER MARIA;AYO CASADO FERNANDO. Apo.Manc.: AYO CASADO FERNANDO. Apo.Sol.:LIMON MACIAS JUAN LUIS. Apo.Manc.: LIMON MACIAS JUAN LUIS. Nombramientos. Apo.Manc.: ROYO GOLDARACENA I脩IGO.Apo.Sol.: ROYO GOLDARACENA I脩IGO;LARRAYA IRIARTE MARIO;LIMON MACIAS JUAN LUIS. Apo.Manc.: LARRAYA IRIARTEMARIO;LIMON MACIAS JUAN LUIS;PLO SUSIN JORGE. Apo.Sol.: PLO SUSIN JORGE. Datos registrales. T 529 , F 187, S 8, H HU1673, I/A 93 ( 1.06.21).

24 de Marzo de 2021
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos.

18 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 529 , F 186, S 8, H HU 1673, I/A 91(11.11.19).

14 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: AMOHALLA ORTEGA FRANCISCO. Apo.Sol.: AMOHALLA ORTEGA FRANCISCO. Nombramientos.Apo.Sol.: LIMON MACIAS JUAN LUIS. Apo.Manc.: LIMON MACIAS JUAN LUIS. Datos registrales. T 529 , F 185, S 8, H HU 1673,I/A 90 ( 8.05.19).

20 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 529 , F 185, S 8, H HU 1673, I/A 89(13.11.18).

10 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Adm. Unico: AYECHU REDIN JUAN MARIA. Datos registrales. T 529 , F 184, S 8, H HU 1673, I/A 87 ( 3.09.18).

Revocaciones. Apo.Sol.: PUERTOLAS LISBONA ENRIQUE;YUSTE DOMINGUEZ CARMEN. Apo.Man.Soli: AMOHALLA ORTEGAFRANCISCO;AMORETTI STEFANO. Nombramientos. Apo.Manc.: AMOHALLA ORTEGA FRANCISCO. Apo.Sol.: AMOHALLAORTEGA FRANCISCO;ROYO GOLDARACENA I脩IGO. Apo.Manc.: ROYO GOLDARACENA I脩IGO;SANCHEZ PEMAN JAVIERMARIA. Apo.Sol.: SANCHEZ PEMAN JAVIER MARIA;AYO CASADO FERNANDO. Apo.Manc.: AYO CASADO FERNANDO. Datosregistrales. T 529 , F 184, S 8, H HU 1673, I/A 88 ( 3.09.18).

24 de Abril de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 529 , F 184, S 8, H HU 1673, I/A 86(17.04.18).

16 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 529 , F 183, S 8, H HU 1673, I/A 85(10.01.17).

29 de Noviembre de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 529 , F 183, S 8, H HU 1673, I/A 84(22.11.16).

30 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORBAIZ AZPILLAGA JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: AYECHU REDIN JUAN MARIA.Datos registrales. T 529 , F 183, S 8, H HU 1673, I/A 83 (24.05.13).

18 de Diciembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Auditor: EZPONDA USOZ ISABEL. Aud.Supl.: MONCOSI MORTE MIGUEL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 529 , F 183, S 8, H HU 1673, I/A 82 (10.12.12).

15 de Marzo de 2012
Reelecciones. Adm. Unico: ORBAIZ AZPILLAGA JOSE LUIS. Datos registrales. T 529 , F 182, S 8, H HU 1673, I/A 80 ( 7.03.12).

Revocaciones. Apoderado: AMORETTI STEFANO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: AMOHALLA ORTEGAFRANCISCO;AMORETTI STEFANO. Datos registrales. T 529 , F 182, S 8, H HU 1673, I/A 81 ( 7.03.12).

17 de Noviembre de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: SOLANES MANERO CARLOS. Apoderado: ONDE CALLEJAS EDUARDO. Apo.Sol.: AZON AZNARFRANCISCO;MURILLO BAILO MAURICIO;MARTINEZ MU脩IO JOSE LUIS. Apoderado: MURILLO BAILO MAURICIO;MARTINLABORDA FERMIN;AZON AZNAR FRANCISCO;SOLANES MANERO CARLOS;AGULLO ACIN ALBERTO;AMORETTISTEFANO;OCHOA VIZCASILLAS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 529 , F 181, S 8, H HU 1673, I/A 79 ( 7.11.11).

18 de Julio de 2011
Nombramientos. Apoderado: AMORETTI STEFANO. Datos registrales. T 529 , F 181, S 8, H HU 1673, I/A 78 ( 8.07.11).

15 de Marzo de 2010
Nombramientos. Auditor: EZPONDA USOZ ISABEL. Aud.Supl.: MONCOSI MORTE MIGUEL. Datos registrales. T 529 , F 180, S 8,H HU 1673, I/A 77 ( 5.03.10).

11 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: PUERTOLAS LISBONA ENRIQUE;YUSTE DOMINGUEZ CARMEN. Datos registrales. T 529 , F 180, S8, H HU 1673, I/A 76 (30.04.09).

07 de Abril de 2009
Revocaciones. Apoderado: OCHOA VIZCASILLAS JOSE MIGUEL. Nombramientos. Apoderado: OCHOA VIZCASILLAS JOSEMIGUEL. Datos registrales. T 529 , F 180, S 8, H HU 1673, I/A 75 (27.03.09).

23 de Marzo de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 529 , F 179, S 8, H HU 1673, I/A 73 (10.03.09).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 529 , F 179, S 8, H HU 1673, I/A 74 (10.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n