Actos BORME de Haz Los Girasoles Sl
23 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ-PINTO OLALQUIAGA JAIME-VICTORIANO. Apo.Manc.: SAAVEDRA RODRIGUEZ DELPALACIO PABLO;PANFILI MARCO. Datos registrales. T 41315 , F 212, S 8, H M 644367, I/A 30 (16.12.22).
19 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: THORPE-COSTA SOPHIA. Nombramientos. Adm. Mancom.: LOPEZ-PINTO OLALQUIAGAJAIME. Datos registrales. T 41315 , F 212, S 8, H M 644367, I/A 28 (12.12.22).
Revocaciones. Apoderado: THORPE-COSTA SOPHIA. Datos registrales. T 41315 , F 212, S 8, H M 644367, I/A 29 (12.12.22).
28 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: IRWIN ADAM CHARLES PEEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: PANFILI MARCO. Datosregistrales. T 41315 , F 209, S 8, H M 644367, I/A 25 (21.06.22).
Revocaciones. Apo.Sol.: IRWIN ADAM CHARLES PEEL. Apoderado: IRWIN ADAM CHARLES PEEL. Datos registrales. T 41315 ,F 209, S 8, H M 644367, I/A 26 (21.06.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PANFILI MARCO. Datos registrales. T 41315 , F 210, S 8, H M 644367, I/A 27 (21.06.22).
24 de Diciembre de 2021Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 23陋. Datos registrales. T 41315 , F 209, S 8, H M 644367, I/A 24 (17.12.21).
12 de Noviembre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: EQUITIX MA 15 HOLDCO LIMITED. Ceses/Dimisiones. Adm.Unico: ARTIGA AMAT ANTONIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: IRWIN ADAM CHARLES PEEL;SAAVEDRA RODRIGUEZ DELPALACIO PABLO;THORPE-COSTA SOPHIA Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los art铆culos 6潞 y 15潞 de los estatutossociales. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Cambiode domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 81 - PISO 11 (MADRID). Datos registrales. T 41315 , F 205, S 8, H M 644367,I/A 21 ( 4.11.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: ARTIGA AMAT ANTONIO;PEREZ FRANCES JOSE. Apoderado: CAMPDERA GUTIERREZENRIQUE;LINARES FERNANDEZ ALEJANDRO. Apo.Sol.: MOLINA MAYO SANTIAGO. Apoderado: GARCIA RENEDO ALVAREZHEVIA CARMEN;LINARES FERNANDEZ ALEJANDRO;ORDO脩EZ ALONSO IGNACIO;SAEZ BEA JULIA;CAMPDERA GUTIERREZENRIQUE;GARCIA RENEDO ALVAREZ HEVIA CARMEN. Datos registrales. T 41315 , F 206, S 8, H M 644367, I/A 22 ( 4.11.21).
Nombramientos. Apoderado: SAAVEDRA RODRIGUEZ DEL PALACIO PABLO;IRWIN ADAM CHARLES PEEL;THORPE-COSTASOPHIA Datos registrales. T 41315 , F 206, S 8, H M 644367, I/A 23 ( 4.11.21).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CASTRO PRIETO LUIS;CONDE VI脩UELAS VICENTE;MENGOTTI MAROTO ALVARO;BLANCOGONZALEZ RAQUEL;DE COTTA LOUSTAU ISABEL;SAENZ DOMINGUEZ ISABEL;SAAVEDRA RODRIGUEZ DEL PALACIOPABLO;IRWIN ADAM CHARLES PEEL;BREUX JORIS. Datos registrales. T 41315 , F 205, S 8, H M 644367, I/A 20 (27.10.21).
23 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: SAEZ BEA JULIA;CAMPDERA GUTIERREZ ENRIQUE;GARCIA RENEDO ALVAREZ HEVIACARMEN. Datos registrales. T 41315 , F 202, S 8, H M 644367, I/A 18 (16.04.21).
31 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: ORDO脩EZ ALONSO IGNACIO. Datos registrales. T 41315 , F 202, S 8, H M 644367, I/A 17(24.03.21).
22 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: DELGADO GARCIA JOSE. Apoderado: DELGADO GARCIA JOSE;DELGADO GARCIA JOSE. Datosregistrales. T 41315 , F 202, S 8, H M 644367, I/A 16 (12.03.21).
10 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CERVERA MIRA FRANCISCO. Datos registrales. T 35863 , F 139, S 8, H M 644367, I/A 15 ( 3.03.21).
08 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: GARCIA RENEDO ALVAREZ HEVIA CARMEN;LINARES FERNANDEZ ALEJANDRO. Datosregistrales. T 35863 , F 139, S 8, H M 644367, I/A 14 ( 1.03.21).
19 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ARTIGA AMAT ANTONIO;PEREZ FRANCES JOSE. Presidente: ARTIGA AMAT ANTONIO.Consejero: FONDEVILA NADAL JAVIER. Secretario: FONDEVILA NADAL JAVIER. Con.Delegado: ARTIGA AMAT ANTONIO.VsecrNoConsj: GARCIA RENEDO ALVAREZ HEVIA CARMEN. Nombramientos. Adm. Unico: ARTIGA AMAT ANTONIO. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 35863 , F139, S 8, H M 644367, I/A 13 (12.02.21).
24 de Julio de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MOLINA MAYO SANTIAGO;CERVERA MIRA FRANCISCO. Datos registrales. T 35863 , F 138, S 8, HM 644367, I/A 12 (17.07.20).
14 de Febrero de 2020Modificaciones estatutarias. 10. Modificado texto del art铆culo 10 de los estatutos. . Datos registrales. T 35863 , F 138, S 8, H M644367, I/A 11 ( 7.02.20).
22 de Enero de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SOL Y DUNAS ENERGIA SL. Datos registrales. T 35863 , F 138, S8, H M 644367, I/A 10 (15.01.20).
11 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: LINARES FERNANDEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 35863 , F 137, S 8, H M 644367, I/A 9 (2.12.19).
21 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: DELGADO GARCIA JOSE. Datos registrales. T 35863 , F 137, S 8, H M 644367, I/A 8 (14.11.19).
22 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: CAMPDERA GUTIERREZ ENRIQUE. Datos registrales. T 35863 , F 136, S 8, H M 644367, I/A 7(15.10.19).
26 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apoderado: MORANTE GONZALEZ JUAN MANUEL. Apo.Manc.: MORANTE GONZALEZ JUAN MANUEL.Apoderado: MARTINEZ GONZALEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 35863 , F 136, S 8, H M 644367, I/A 6 (18.09.18).
01 de Marzo de 2018Nombramientos. VsecrNoConsj: GARCIA RENEDO ALVAREZ HEVIA CARMEN. Con.Delegado: ARTIGA AMAT ANTONIO. Datosregistrales. T 35863 , F 136, S 8, H M 644367, I/A 5 (22.02.18).
28 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FONDEVILA NADAL FRANCISCO JAVIER. Consejero: MORANTE GONZALEZ JUAN MANUEL.Nombramientos. Consejero: FONDEVILA NADAL JAVIER. Secretario: FONDEVILA NADAL JAVIER. Ampliaci贸n de capital.Capital: 50.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 53.100,00 Euros. Datos registrales. T 35863 , F 136, S 8, H M 644367, I/A 4(21.08.17).
18 de Agosto de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: RENSOLENERGIA SL. Datos registrales. T 35863 , F 135, S 8, HM 644367, I/A 3 (10.08.17).
29 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: ARTIGA AMAT ANTONIO;PEREZ FRANCES JOSE. Apoderado: MORANTE GONZALEZ JUANMANUEL. Apo.Manc.: MORANTE GONZALEZ JUAN MANUEL;DELGADO GARCIA JOSE. Apoderado: MARTINEZ GONZALEZBEATRIZ;DELGADO GARCIA JOSE. Datos registrales. T 35863 , F 134, S 8, H M 644367, I/A 2 (19.05.17).
19 de Mayo de 2017Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 11.04.17. Objeto social: La realizaci贸n de toda clase de actividades, obras y serviciospropios o relacionados con los negocios de: a.- promoci贸n y desarrollo de proyectos de generaci贸n de electricidad mediante tecnolog铆afotovoltaica, pudiendo para ello, comprar y vender terrenos, suscribir contratos de arrendamiento... Domicilio: C/ GOYA 6 2潞 (MADRID).Capital: 3.100,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SUNCO CAPITAL DEVELOPMENT FUND I FCR.Nombramientos. Consejero: ARTIGA AMAT ANTONIO;MORANTE GONZALEZ JUAN MANUEL;PEREZ FRANCES JOSE.Presidente: ARTIGA AMAT ANTONIO. SecreNoConsj: FONDEVILA NADAL FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 35863 , F132, S 8, H M 644367, I/A 1 ( 9.05.17).