Buscador CIF Logo

Actos BORME Health Transportation Group Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Health Transportation Group Sl

Actos BORME Health Transportation Group Sl - B87973145

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Health Transportation Group Sl con CIF B87973145

🔙 Perfil de Health Transportation Group Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Health Transportation Group Sl

02 de Octubre de 2023
Nombramientos. Consejero: GONZAGA HIGUERO ROBLES LUIS. Datos registrales. T 41975 , F 192, S 8, H M 659004, I/A 25(22.09.23).

04 de Septiembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: HIGUERO ROBLES LUIS-GONZAGA. Vicepresid.: HIGUERO ROBLES LUIS-GONZAGA.Cons.Del.Sol: HIGUERO ROBLES LUIS-GONZAGA. Nombramientos. Consejero: MOYA GARCIA RENEDO GUILLERMO.Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 41975 , F188, S 8, H M 659004, I/A 22 (28.08.23).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: HIGUERO ROBLES LUIS GONZAGA. Nombramientos. Con.Delegado: MOYA GARCIA RENEDOGUILLERMO. Vicepresid.: MOYA GARCIA RENEDO GUILLERMO. Datos registrales. T 41975 , F 189, S 8, H M 659004, I/A 23(28.08.23).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 41975 , F192, S 8, H M 659004, I/A 24 (28.08.23).

08 de Junio de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: MENCHACA ARITZ ARITZA. Datos registrales. T 41975 , F 185, S 8, H M 659004, I/A 21 ( 1.06.23).

03 de Febrero de 2023
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 41975 , F 185, S 8, H M 659004, I/A 20 (27.01.23).

02 de Febrero de 2023
Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 41975 , F 184, S 8, H M 659004, I/A 19 (26.01.23).

12 de Enero de 2023
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: E-CENTER NETWORK CASTILLA Y LEON SL. SUPSAR INVEST SL. Datosregistrales. T 41975 , F 182, S 8, H M 659004, I/A 18 ( 4.01.23).

14 de Febrero de 2022
Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 41975 , F 181, S 8, H M 659004, I/A 17 ( 7.02.22).

03 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: LAMARCA ALCAIDE XAVIER;SANCHO MIGUEL FRANCESC. Nombramientos. Apoderado: PINOFERRE NURIA. Datos registrales. T 41975 , F 181, S 8, H M 659004, I/A 16 (27.01.22).

02 de Noviembre de 2021
Cambio de domicilio social. C/ PRINCESA 31 5ª 6 (MADRID). Cambio de objeto social. (a) La prestación de serviciosestratégicos de dirección, jurídicos, fiscales, administrativos, financieros -exclusivamente a sociedades filiales por lo que constituye unade la exclusiones previstas en el artículo 139.1.b de la Ley del Mercado de Valores-, contables, administrativos;. Datos registrales. T41975 , F 180, S 8, H M 659004, I/A 15 (25.10.21).

05 de Agosto de 2021
Declaración de unipersonalidad. Socio único: ALBA HOLDCO SARL. Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DELGADO GILROBERTO. VsecrNoConsj: GIMENO VILARRASA BEATRIZ. Consejero: MAGDALENO FERNANDEZ CARLOS;GUELL AMPUEROJOSE JOAQUIN;SEGURA ROMAGOSA EDUARDO;COURET MELENDEZ CARLOS;UGUET ADROVER GABRIEL. Presidente:GUELL AMPUERO JOSE JOAQUIN. Consejero: GORDILLO CRUZ CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: MIRAGALLMARTINEZ MERCEDES. Consejero: AMMOUN ROGER GEORGES;PETERS ANTHONY EDWARD;SARADCHANDRA KUMAR RAM.Presidente: SARADCHANDRA KUMAR RAM. Vicepresid.: HIGUERO ROBLES LUIS-GONZAGA. Datos registrales. T 40048 , F 224,S 8, H M 659004, I/A 12 (29.07.21).

Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: HIGUERO ROBLES LUIS-GONZAGA. Revocaciones. Apo.Manc.: MAGDALENO FERNANDEZCARLOS. Nombramientos. Cons.Del.Sol: HIGUERO ROBLES LUIS-GONZAGA. Otros conceptos: MODIFICADA LA FORMA DEACTUACION DE DON LUIS GONZAGA HIGUERO ROBLES COMO CONSEJERO DELEGADO, ATRIBUIDAS EN LA INSCRIPCION7º DE LA HOJA DE ESTA SOCIEDAD, QUE PASARA A SER CONSEJERO DELEGADO SOLIDARIO. Datos registrales. T 40048 , F225, S 8, H M 659004, I/A 13 (29.07.21).

Modificaciones estatutarias. Creacion del articulo 7º Bis en los estatutos sociales . Datos registrales. T 41975 , F 180, S 8, H M659004, I/A 14 (29.07.21).

03 de Febrero de 2021
Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 40048 , F 223, S 8, H M 659004, I/A 10 (27.01.21).

Ampliacion del objeto social. (a) El transporte sanitario, entendiendo por tal el transporte y traslado de personas enfermas,accidentadas, impedidas, incapacitadas y pacientes de hospitales, y en general a toda persona que por razones sanitarias lo requieran,así como el transporte de personal sanitario, instrumentos médicos y. Datos registrales. T 40048 , F 223, S 8, H M 659004, I/A 11(27.01.21).

11 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HIGUERO ROBLES LUIS GONZAGA;MENCHACA ARITZ ARITZA;LOPEZ TORTOSA ALEJANDRO.Apo.Sol.: MIRAGALL MARTINEZ MERCEDES;LAMARCA ALCAIDE XAVIER;MARTIN ASENJO MARIA ASCENSION;PEREZ PRIETORAUL;GARCIA MUÑOZ ABEL;SANCHO MIGUEL FRANCESC;ARGUELLES BALLETBO JOSE;VALDESOGO ROBLES JOSELUIS;PEREZ FERNANDEZ JESUS;MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS;MAGDALENO FERNANDEZ CARLOS;MALET FARRE DANIEL.Datos registrales. T 36799 , F 57, S 8, H M 659004, I/A 9 ( 4.02.20).

10 de Abril de 2019
Nombramientos. Consejero: MENCHACA ARITZ ARITZA. Datos registrales. T 36799 , F 57, S 8, H M 659004, I/A 8 ( 3.04.19).

08 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: UGUET ADROVER GABRIEL. Nombramientos. Co.De.Ma.So: HIGUERO ROBLES LUIS-GONZAGA. Apo.Manc.: MAGDALENO FERNANDEZ CARLOS. Datos registrales. T 36799 , F 54, S 8, H M 659004, I/A 7 ( 1.04.19).

12 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: VOGLER KURT THEO ECKART;FORTUNY CAPITAL ADVISORY SL;JEREZ BURDEUS SONIA.Representan: GORDILLO CRUZ CARLOS. Consejero: PELLEGRI STEFANO. Nombramientos. Consejero: GORDILLO CRUZCARLOS;HIGUERO ROBLES LUIS-GONZAGA. VsecrNoConsj: GIMENO VILARRASA BEATRIZ. Datos registrales. T 36799 , F 53,S 8, H M 659004, I/A 6 ( 5.03.19).

19 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 36799 , F 53, S 8, H M 659004, I/A 5 (12.12.18).

23 de Julio de 2018
Nombramientos. Consejero: JEREZ BURDEUS SONIA. Datos registrales. T 36799 , F 53, S 8, H M 659004, I/A 4 (16.07.18).

02 de Enero de 2018
Nombramientos. Co.De.Ma.So: UGUET ADROVER GABRIEL. Datos registrales. T 36799 , F 50, S 8, H M 659004, I/A 3 (22.12.17).

19 de Diciembre de 2017
Ampliación de capital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.020.000,00 Euros. Datos registrales. T 36799 , F 49, S 8,H M 659004, I/A 2 (12.12.17).

18 de Diciembre de 2017
Constitución. Comienzo de operaciones: 30.11.17. Objeto social: (a) El transporte sanitario, entendiendo por tal el transporte y

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información