Actos BORME de Hearst España Sl
19 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: MOLETTO GIACOMO;SACRISTAN HERRERO MARIA JESUS;DIAZ CORTES IGNACIO;PORTILLADE FRUTOS CESAR. Apoderado: PASEIRO GARAYZABAL RAUL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MOLETTO GIACOMO;DIAZCORTES IGNACIO;PORTILLA DE FRUTOS CESAR;PASEIRO GARAYZABAL RAUL;SORRENTINO MARCELLO. Datos registrales.T 38380 , F 28, S 8, H M 134136, I/A 71 (12.11.21).
22 de Julio de 2021Reducción de capital. Importe reducción: 2.995.311,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.004.692,58 Euros. Datos registrales. T 38380, F 27, S 8, H M 134136, I/A 70 (15.07.21).
15 de Julio de 2021Nombramientos. Vicepresid.: MARTIN CONEJERO CRISTINA. Fe de erratas: Se omitió por error en la incricpión 69ª la publicacióndel nombramiento de MARTIN CONEJERO CRISTINA como vicepresidenta. Datos registrales. T 38380 , F 27, S 8, H M 134136, I/A69 (31.03.21).
09 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: HORNE SIMON PETER BARRY. Presidente: MARTIN CONEJERO CRISTINA. Nombramientos.Consejero: CHIRICHELLA DEBRA-ANN. Presidente: CHIRICHELLA DEBRA-ANN. Datos registrales. T 38380 , F 27, S 8, H M134136, I/A 69 (31.03.21).
07 de Abril de 2021Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 11 Y 17 Y CREACION DEL ARTICULO 18 BIS.. Datosregistrales. T 38380 , F 25, S 8, H M 134136, I/A 68 (29.03.21).
29 de Marzo de 2021Cambio de domicilio social. AVDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA 3 (MADRID). Datos registrales. T 38380 , F 25, S 8, H M134136, I/A 67 (22.03.21).