Actos BORME de Heril Inversiones 2008 Sl
22 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ZABALA MURUA JAVIER. Nombramientos. Consejero: LOPEZ PINTO FERNANDEZ DENAVARRETE VICTORIANO. Datos registrales. T 26143 , F 219, S 8, H M 471184, I/A 16 (15.09.20).
23 de Enero de 2018Cambio de domicilio social. C/ MONTALBAN 7 (MADRID). Datos registrales. T 26143 , F 218, S 8, H M 471184, I/A 15 (12.01.18).
16 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Representan: DE BARTOLOME PALOMO JOSE MANUEL. Nombramientos. Representan: POLO ROSADODIONISIO. Datos registrales. T 26143 , F 218, S 8, H M 471184, I/A 14 ( 5.10.17).
18 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MELDON INVERSIONES 2008 SL;BETA MELDON SL;ALFA MELDON SL. Presidente: ALFAMELDON SL. Representan: ZABALA MURUA JAVIER;DE BARTOLOME PALOMO JOSE MANUEL;VELAZQUEZ GOMEZ DAVID.Nombramientos. Representan: DE BARTOLOME PALOMO JOSE MANUEL. Consejero: ZABALA MURUA JAVIER;VELAZQUEZGOMEZ DAVID;ILEAR SERVICIOS SL. Presidente: VELAZQUEZ GOMEZ DAVID. Datos registrales. T 26143 , F 217, S 8, H M471184, I/A 13 (11.01.16).
20 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: TOUBES TORRES PALOMA GUADALUPE. Secretario: PENDAS AGUIRRE ANGELFRANCISCO. Nombramientos. VsecrNoConsj: REY CARDOS ERNESTO. SecreNoConsj: BELENGUER MULA JOSE-VICENTE.Datos registrales. T 26143 , F 217, S 8, H M 471184, I/A 12 (10.07.15).
03 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: VILA ABELLAN GARCIA MARIA ISABEL. Secretario: RIVILLA CALLE BLANCA.Nombramientos. Secretario: PENDAS AGUIRRE ANGEL FRANCISCO. VsecrNoConsj: TOUBES TORRES PALOMA GUADALUPE.Datos registrales. T 26143 , F 216, S 8, H M 471184, I/A 11 (27.05.13).
22 de Febrero de 2013Revocaciones. Apoderado: CLAVERIA GARCIA JUAN JOSE. Nombramientos. Apoderado: VELAZQUEZ GOMEZ DAVID. Datosregistrales. T 26143 , F 214, S 8, H M 471184, I/A 10 (15.02.13).
19 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Representan: CLAVERIA GARCIA JUAN JOSE. Nombramientos. Representan: VELAZQUEZ GOMEZ DAVID.Datos registrales. T 26143 , F 25, S 8, H M 471184, I/A 9 (11.02.13).
11 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Representan: CLAVERIA GARCIA JUAN JOSE;DE BARTOLOME PALOMO JOSE MANUEL. Consejero:AHORRO CORPORACION DESARROLLO SGECR SA;AHORRO CORPORACION INFRAESTRUCTURAS 2 SCR SA DE RE.Presidente: AHORRO CORPORACION INFRAESTRUCTURAS 2 SCR SA DE RE. Nombramientos. Representan: CLAVERIA
09 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: AHORRO CORPORACION FINANCIERA S V SA. Representan: ZABALA MURUA JAVIER.Nombramientos. Consejero: MELDON INVERSIONES 2008 SL. Representan: ZABALA MURUA JAVIER. Datos registrales. T26143 , F 24, S 8, H M 471184, I/A 7 (26.04.11).
30 de Julio de 2010Nombramientos. VsecrNoConsj: VILA ABELLAN GARCIA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 26143 , F 23, S 8, H M 471184, I/A6 (20.07.10).
05 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: ALEGRE ALONSO IVAN. Datos registrales. T 26143 , F 23, S 8, H M 471184, I/A 5 (22.04.09).
02 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: CLAVERIA GARCIA JUAN JOSE. Datos registrales. T 26143 , F 20, S 8, H M 471184, I/A 4(23.03.09).
01 de Abril de 2009P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 26143 , F 20, S 8, H M 471184, I/A 3 (18.03.09).
25 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RINO ASESORES SLP. Representan: RIBALTA NOGUERA CRISTINA. Nombramientos.Representan: CLAVERIA GARCIA JUAN JOSE. Consejero: AHORRO CORPORACION DESARROLLO SGECR SA;AHORROCORPORACION FINANCIERA S V SA;AHORRO CORPORACION INFRAESTRUCTURAS 2 SCR SA DE RE. Representan: DEBARTOLOME PALOMO JOSE MANUEL;ZABALA MURUA JAVIER. SecreNoConsj: RIVILLA CALLE BLANCA. Presidente: AHORROCORPORACION INFRAESTRUCTURAS 2 SCR SA DE RE. VsecrNoConsj: DEL PUEYO RODRIGUEZ ELENA. Ampliaci贸n decapital. Capital: 2.496.988,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.500.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social. PASEO CASTELLANA 89(MADRID). Datos registrales. T 26143 , F 18, S 8, H M 471184, I/A 2 (12.03.09).