Actos BORME de Hermans Systems Sa
13 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 4188, L 4188, F 28, S 8, H PO 7749, I/A 29 ( 4.01.23).
02 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GOMEZ FORTES GERMAN. Nombramientos. Adm. Unico: CARTERA BASE SL. Datosregistrales. T 4188, L 4188, F 28, S 8, H PO 7749, I/A 28 (26.05.22).
14 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ FORTES GERMAN. Presidente: GOMEZ FORTES GERMAN. Consejero: GOMEZ FORTESDORINDA. Secretario: GOMEZ FORTES DORINDA. Consejero: PUENTE GOMEZ BEATRIZ. Cons.Del.Sol: GOMEZ FORTESGERMAN;GOMEZ FORTES DORINDA. Revocaciones. Apoderado: GOMEZ FORTES DORINDA. Apo.Sol.: GOMEZ FORTESDORINDA. Nombramientos. Adm. Unico: GOMEZ FORTES GERMAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 4188, L 4188, F 28, S 8, H PO 7749, I/A 27 ( 6.07.21).
19 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 4188, L 4188, F 27, S 8, H PO 7749, I/A 26 ( 8.01.21).
12 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 4188, L 4188, F 27, S 8, H PO 7749, I/A 25 (29.11.18).
29 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GOMEZ FORTES GERMAN. Nombramientos. Consejero: GOMEZ FORTES GERMAN.
27 de Marzo de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 307,02 Euros. Desembolsado: 307,02 Euros. Resultante Suscrito: 60.507,02 Euros. ResultanteDesembolsado: 60.507,02 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INVERSIONES BASE SL. Datos registrales. T2124, L 2124, F 182, S 8, H PO 7749, I/A 23 (16.03.17).
13 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 2124, L 2124, F 182, S 8, H PO 7749, I/A 22 ( 3.01.17).
28 de Marzo de 2016Revocaciones. Apoderado: GARCIA GONZALEZ MANUEL. Datos registrales. T 2124, L 2124, F 182, S 8, H PO 7749, I/A 21(14.03.16).
15 de Febrero de 2016Nombramientos. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 2124, L 2124, F 182, S 8, H PO 7749, I/A 20 ( 8.02.16).
23 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: PUENTE GOMEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 2124, L 2124, F 181, S 8, H PO 7749, I/A 19(12.03.15).
19 de Diciembre de 2014Nombramientos. Auditor: AB. AUDASO SL. Datos registrales. T 2124, L 2124, F 180, S 8, H PO 7749, I/A 18 (10.12.14).
22 de Mayo de 2014Reelecciones. Adm. Unico: GOMEZ FORTES GERMAN. Datos registrales. T 2124, L 2124, F 180, S 8, H PO 7749, I/A 17(15.05.14).
28 de Marzo de 2012Cambio de domicilio social. AVDA ALCALDE GREGORIO ESPINO 34 (VIGO). Datos registrales. T 2124, L 2124, F 180, S 8, HPO 7749, I/A 16 (16.03.12).
15 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: GOMEZ FORTES DORINDA. Datos registrales. T 2124, L 2124, F 179, S 8, H PO 7749, I/A 15 (3.02.12).