Actos BORME de Hermu 2 Promotora Industrial Sa
17 de Febrero de 2021Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: COMERCIAL INDUSTRIAL DE AUTOMOVILES Y RECAMBIOS SA. MOTORVITORIA SA. VITORIANA DE AUTOMOVILES SA VIASA. GASTEIZ MOTOR SA GAMOSA. Datos registrales. T 1521 , F 165, S 8, H
25 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: MUGICA VELA JORGE. Presidente: MUGICA VELA JORGE. Consejero: MUGICA VELA ESTHER.Secretario: MUGICA VELA ESTHER. Consejero: CORRES IBISATE FERNANDO. Nombramientos. Consejero: MUGICA VELAJORGE;MUGICA VELA ESTHER;MUGICA VELA ANA. Presidente: MUGICA VELA JORGE. Secretario: MUGICA VELA ESTHER.Datos registrales. T 1521 , F 165, S 8, H VI 5173, I/A 25 (12.06.20).
11 de Abril de 2019Reelecciones. Consejero: MUGICA VELA JORGE. Presidente: MUGICA VELA JORGE. Consejero: MUGICA VELA ESTHER.Secretario: MUGICA VELA ESTHER. Consejero: CORRES IBISATE FERNANDO. Datos registrales. T 1521 , F 164, S 8, H VI 5173,I/A 23 (27.03.19).
Nombramientos. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. Datos registrales. T 1521 , F 165, S 8, H VI 5173,I/A 24 (27.03.19).
21 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: MUGICA VELA JORGE. Datos registrales. T 1521 , F 163, S 8, H VI 5173, I/A 22 ( 9.05.18).
31 de Mayo de 2016Nombramientos. Aud.C.Con.: LV AUDINORTE S.L. Otros conceptos: Se revoca al Auditor Titular de Cuentas Consolidadas, DonLu铆s Valle Fernandez, para el ejercicio 2.015.- Datos registrales. T 1521 , F 162, S 8, H VI 5173, I/A 21 (12.05.16).
13 de Mayo de 2016Revocaciones. Auditor: VALLE FERNANDEZ LUIS. Otros conceptos: La revocaci贸n del auditor de cuentas DON LUIS VALLEFERNANDEZ, es para el ejercicio 2.015, como auditor titular. Datos registrales. T 1521 , F 162, S 8, H VI 5173, I/A 20 ( 4.05.16).
15 de Abril de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 589.340,60 Euros. Desembolsado: 589.340,60 Euros. Resultante Suscrito: 3.904.979,47 Euros.Resultante Desembolsado: 3.904.979,47 Euros. Datos registrales. T 1521 , F 161, S 8, H VI 5173, I/A 19 ( 7.04.16).
23 de Marzo de 2016Nombramientos. Auditor: VALLE FERNANDEZ LUIS. Datos registrales. T 1521 , F 161, S 8, H VI 5173, I/A 18 ( 1.03.16).
16 de Abril de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 150.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.315.638,87 Euros. Otros conceptos: Serenumeran las acciones en que se divide el capital social y se modifica el art铆culo 6潞 estatutario. Datos registrales. T 1521 , F 160, S8, H VI 5173, I/A 17 ( 7.04.15).
27 de Diciembre de 2013Reelecciones. Aud.C.Con.: VALLE FERNANDEZ LUIS. Aud.Su.C.Con: IRASTORZA MADARIAGA JOSEBA ERRAMON. Datosregistrales. T 1521 , F 160, S 8, H VI 5173, I/A 16 (11.12.13).
25 de Noviembre de 2013Reelecciones. Consejero: MUGICA PINEDO ANGEL. Presidente: MUGICA PINEDO ANGEL. Consejero: MUGICA VELA ESTHER.Secretario: MUGICA VELA ESTHER. Consejero: MUGICA VELA JORGE;MUGICA PINEDO FRANCISCO;CORRES IBISATEFERNANDO. Datos registrales. T 1521 , F 159, S 8, H VI 5173, I/A 14 (13.11.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MUGICA PINEDO ANGEL. Presidente: MUGICA PINEDO ANGEL. Consejero: MUGICA VELAESTHER. Secretario: MUGICA VELA ESTHER. Consejero: MUGICA VELA JORGE;MUGICA PINEDO FRANCISCO;CORRESIBISATE FERNANDO. Nombramientos. Consejero: MUGICA VELA JORGE. Presidente: MUGICA VELA JORGE. Consejero:MUGICA VELA ESTHER. Secretario: MUGICA VELA ESTHER. Consejero: CORRES IBISATE FERNANDO. Datos registrales. T1521 , F 160, S 8, H VI 5173, I/A 15 (13.11.13).
19 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: MUGICA VELA ESTHER. Nombramientos. Apoderado: MUGICA VELA ESTHER;MUGICA PINEDOANGEL. Datos registrales. T 761 , F 186, S 8, H VI 5173, I/A 13 ( 5.12.12).
12 de Agosto de 2011Reelecciones. Aud.C.Con.: VALLE FERNANDEZ LUIS. Aud.Su.C.Con: IRASTORZA MADARIAGA JOSEBA ERRAMON. Datosregistrales. T 761 , F 186, S 8, H VI 5173, I/A 12 ( 1.08.11).
15 de Septiembre de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 321.607,12 Euros. Resultante Suscrito: 3.465.888,87 Euros. Datos registrales. T 761 , F185, S 8, H VI 5173, I/A 11 ( 4.08.09).